Skip to main content

Bill C-13

If you have any questions or comments regarding the accessibility of this publication, please contact us at accessible@parl.gc.ca.

R.S., c. 1 (5th Supp.)

Income Tax Act
Loi de l’impôt sur le revenu
L.R., ch. 1 (5e suppl.)

161. (1) Paragraph 18(1)(t) of the Income Tax Act is replaced by the following:
161. (1) L’alinéa 18(1)t) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
Payments under different acts

(t) any amount paid or payable

(i) under this Act (other than tax paid or payable under Part XII.2 or Part XII.6),

(ii) as interest under Part IX of the Excise Tax Act, or

(iii) as interest under the Air Travellers Security Charge Act;
t) toute somme payée ou à payer :
Paiements en vertu de diverses lois

(i) en vertu de la présente loi, sauf l’impôt payé ou à payer en vertu des parties XII.2 ou XII.6,

(ii) à titre d’intérêts en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise,

(iii) à titre d’intérêts en vertu de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien;

(2) Subsection (1) applies to taxation years that begin on or after April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant le 1er avril 2007 ou par la suite.
162. (1) Subsection 161.4(2) of the Act is replaced by the following:
162. (1) Le paragraphe 161.4(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Minister

(2) If, at any time, the total of all amounts payable by the Minister to a person under this Act does not exceed two dollars, the Minister may apply those amounts against any amount owing, at that time, by the person to Her Majesty in right of Canada. However, if the person, at that time, does not owe any amount to Her Majesty in right of Canada, those amounts payable are deemed to be nil.
(2) Si, à un moment donné, le total des sommes à payer par le ministre à une personne en vertu de la présente loi est égal ou inférieur à deux dollars, le ministre peut les déduire de toute somme dont la personne est alors redevable à Sa Majesté du chef du Canada. Toutefois, si la personne n’est alors redevable d’aucune somme à Sa Majesté du chef du Canada, les sommes à payer par le ministre sont réputées nulles.
Ministre

(2) Subsection (1) applies to amounts owing on or after April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux sommes exigibles le 1er avril 2007 ou par la suite.
163. (1) Section 164 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
163. (1) L’article 164 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Withholding of refunds

(2.01) The Minister shall not, in respect of a taxpayer, refund, repay, apply to other debts or set-off amounts under this Act at any time unless all returns of which the Minister has knowledge and that are required to be filed by the taxpayer at or before that time under this Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, 2001 and the Excise Tax Act have been filed with the Minister.
(2.01) Une somme n’est remboursée, restituée, appliquée en réduction d’autres dettes ou compensée en vertu de la présente loi à un moment donné relativement à un contribuable qu’une fois présentées au ministre toutes les déclarations dont celui-ci a connaissance et que le contribuable avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur la taxe d’accise.
Restriction

(2) Subsection (1) comes into force on April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
164. (1) Subsection 220(3) of the Act is replaced by the following:
164. (1) Le paragraphe 220(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Extensions for returns

(3) The Minister may at any time extend the time for making a return under this Act.
(3) Le ministre peut en tout temps proroger le délai fixé pour faire une déclaration en vertu de la présente loi.
Prorogations de délais pour les déclarations

(2) Section 220 of the Act is amended by adding the following after subsection (3.7):
(2) L’article 220 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.7), de ce qui suit :
Dishonoured instruments

(3.8) For the purposes of this Act and section 155.1 of the Financial Administration Act

(a) any charge that becomes payable at any time by a person under the Financial Administration Act in respect of an instrument tendered in payment or settlement of an amount that is payable or remittable under this Act is deemed to be an amount that becomes payable or remittable by the person at that time under this Act;

(b) sections 152, 158 and 159, subsections 161(1), (2) and (11), sections 162 to 167 and Division J of this Part are applicable to the amount deemed to become payable or remittable by this subsection with any modifications that the circumstances require;

(c) Part II of the Interest and Administrative Charges Regulations does not apply to the charge; and

(d) any debt under subsection 155.1(3) of the Financial Administration Act in respect of the charge is deemed to be extinguished at the time the total of the amount and any applicable interest under this Act is paid.
(3.8) Pour l’application de la présente loi et de l’article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques :
Effets refusés

a) les frais qui deviennent payables par une personne à un moment donné en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques relativement à un effet offert en paiement ou en règlement d’une somme à payer ou à verser en vertu de la présente loi sont réputés être une somme qui devient à payer ou à verser par la personne à ce moment en vertu de la présente loi;

b) les articles 152, 158 et 159, les paragraphes 161(1), (2) et (11), les articles 162 à 167 et la section J de la présente partie s’appliquent à la somme qui est réputée devenir à payer ou à verser en vertu du présent paragraphe, avec les adaptations nécessaires;

c) la partie II du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs ne s’applique pas aux frais;

d) toute créance relative aux frais, visée au paragraphe 155.1(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques, est réputée avoir été éteinte au moment où le total de la somme et des intérêts applicables en vertu de la présente loi est versé.

(3) Subsection (1) applies in respect of extensions granted on or after April 1, 2007.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux prorogations accordées le 1er avril 2007 ou par la suite.
(4) Subsection (2) applies in respect of any instrument that is dishonoured on or after April 1, 2007.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux effets refusés le 1er avril 2007 ou par la suite.
165. (1) Section 221.2 of the Act is renumbered as subsection 221.2(1) and is amended by adding the following:
165. (1) L’article 221.2 de la même loi devient le paragraphe 221.2(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Re-appropriation of amounts

(2) Where a particular amount was appropriated to an amount (in this section referred to as the “debt”) that is or may become payable by a person under this Act, the Excise Tax Act, the Air Travellers Security Charge Act or the Excise Act, 2001, the Minister may, on application by the person, appropriate the particular amount, or a part of it, to another amount that is or may become payable under any of those Acts and, for the purposes of any of those Acts,

(a) the later appropriation is deemed to have been made at the time of the earlier appropriation;

(b) the earlier appropriation is deemed not to have been made to the extent of the later appropriation; and

(c) the particular amount is deemed not to have been paid on account of the debt to the extent of the later appropriation.
(2) Lorsqu’un montant est affecté à une somme (appelée « dette » au présent article) qui est ou peut devenir payable par une personne en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien ou de la Loi de 2001 sur l’accise, le ministre peut, à la demande de la personne, affecter tout ou partie du montant à une autre somme qui est ou peut devenir ainsi payable. Pour l’application de ces lois :
Réaffectation de montants

a) la seconde affectation est réputée effectuée au même moment que la première;

b) la première affectation est réputée ne pas avoir été effectuée jusqu’à concurrence de la seconde;

c) le montant est réputé ne pas avoir été payé au titre de la dette jusqu’à concurrence de la seconde affectation.

(2) Subsection (1) applies in respect of re-appropriation applications made on or after April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux demandes de réaffectations présentées le 1er avril 2007 ou par la suite.
166. (1) Paragraph 225.1(1)(e) of the Act is repealed.
166. (1) L’alinéa 225.1(1)e) de la même loi est abrogé.
(2) Subsection (1) comes into force on April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2007.
Conditional Amendment
Modifications conditionnelles
Conditional amendment

167. If this Act receives royal assent after April 1, 2007,

(a) every reference in this Part to “April 1, 2007” is replaced by the day of that assent; and

(b) every reference in this Part to “March 31, 2007” is replaced by the day before the day of that assent.
167. En cas de sanction de la présente loi après le 1er avril 2007 :
Modifications conditionnelles

a) la mention « 1er avril 2007 » dans la présente partie est remplacée par la mention de la date de la sanction;

b) la mention « 31 mars 2007 » dans la présente partie est remplacée par la mention de la date de la veille de la sanction.

PART 6
PARTIE 6
UNIVERSAL CHILD CARE BENEFIT
PRESTATION UNIVERSELLE POUR LA GARDE D’ENFANTS
Enactment of Act
Édiction de la Loi
Enactment of Act

168. The Universal Child Care Benefit Act is enacted as follows:
168. Est édictée la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants, dont le texte suit :
Édiction de la Loi

An Act to assist families by supporting their child care choices through direct financial support and to make consequential and related amendments to certain Acts
Loi prévoyant un appui financier direct aux familles pour les aider à faire des choix en matière de garde d’enfants et apportant des modifications corrélatives à certaines lois
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Universal Child Care Benefit Act.
1. Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants.
Titre abrégé

INTERPRETATION
DÉFINITIONS
Definitions

2. The following definitions apply in this Act.
“eligible individual”
« particulier admissible »

“eligible individual” means a person who is an eligible individual for the purpose of Subdivision a.1 of Division E of Part I of the Income Tax Act.
“Minister”
« ministre »

“Minister” means the Minister of Human Resources and Skills Development.
“qualified dependant”
« personne à charge admissible »

“qualified dependant” means a person who has not attained the age of six years and who is a qualified dependant for the purpose of Subdivision a.1 of Division E of Part I of the Income Tax Act.
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Définitions

« ministre » Le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences.
« ministre »
Minister

« particulier admissible » Particulier admissible pour l’application de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu.
« particulier admissible »
eligible individual

« personne à charge admissible » Personne à charge admissible pour l’application de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui est âgée de moins de six ans.
« personne à charge admissible »
qualified dependant

PURPOSE
OBJET DE LA LOI
Purpose

3. The purpose of this Act is to assist families by supporting their child care choices through direct financial support to a maximum of $1,200 per year in respect of each of their children who has not attained the age of six years.
3. La présente loi a pour objet d’apporter un appui financier direct aux familles, jusqu’à concurrence d’une somme annuelle de 1 200 $ par enfant, pour les aider à faire des choix en matière de garde à l’égard de leurs enfants de moins de six ans.
Objet

BENEFIT
PRESTATION
Amount of payment

4. (1) The Minister shall pay to an eligible individual, for each month at the beginning of which he or she is an eligible individual, a benefit of $100 for each child who is a qualified dependant of the individual at the beginning of that month.
4. (1) Le ministre verse au particulier admissible, pour chaque mois au début duquel il a cette qualité, une prestation de 100 $ à l’égard de tout enfant qui est une personne à charge admissible de celui-ci au début du mois.
Versement de la prestation

Limitation

(2) The benefit may not be paid in respect of any month before July, 2006.
(2) La prestation ne peut être versée à l’égard d’un mois antérieur à juillet 2006.
Restriction

Benefit cannot be charged, etc.

5. A benefit

(a) is not subject to the operation of any law relating to bankruptcy or insolvency;

(b) cannot be assigned, charged, attached or given as security;

(c) cannot be retained by way of deduction, set-off or, in Quebec, compensation, under any Act of Parliament other than this Act; and

(d) is not garnishable moneys for the purposes of the Family Orders and Agreements Enforcement Assistance Act.
5. Les prestations :
Incessibilité

a) sont soustraites à l’application des règles de droit relatives à la faillite ou à l’insolvabilité;

b) sont incessibles et insaisissables et ne peuvent être grevées ni données pour sûreté;

c) ne peuvent être retenues par voie de déduction ou de compensation en application d’une loi fédérale autre que la présente loi;

d) ne constituent pas des sommes saisissables pour l’application de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales.

Return of overpayment or erroneous payment

6. (1) A person who has received or obtained a benefit to which the person is not entitled, or a benefit in excess of the amount of the benefit to which the person is entitled, shall, as soon as possible, repay the amount of the benefit or the excess amount, as the case may be.
6. (1) La personne qui a reçu une prestation à laquelle elle n’a pas droit, ou à qui a été versée une prestation dont le montant excédait celui auquel elle avait droit, doit, dans les meilleurs délais, restituer le trop-perçu.
Restitution du trop-perçu

Recovery as a debt due to Her Majesty

(2) The amount of the overpayment or erroneous payment constitutes a debt due to Her Majesty, as of the day on which it was paid, that may be recovered by the Minister of National Revenue.
(2) Les sommes versées indûment ou en excédent constituent, à compter de la date du versement, des créances de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre par le ministre du Revenu national.
Recouvrement

Limitation period

7. (1) Subject to this section, no action or proceedings shall be taken to recover money owing under this Act after the expiry of the six-year limitation period that begins on the day on which the money becomes due and payable.
7. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, toute poursuite visant le recouvrement d’une créance au titre de la présente loi se prescrit par six ans à compter de la date à laquelle la créance devient exigible.
Prescription

Deduction and set-off

(2) Money owing by a person under this Act may be recovered at any time by way of deduction from, set-off against or, in Quebec, compensation against, any sum of money, including a benefit under this Act, that may be due or payable by Her Majesty in right of Canada to the person, other than an amount payable under section 122.61 of the Income Tax Act.
(2) Le recouvrement, par voie de compensation ou de déduction, du montant d’une créance exigible d’une personne au titre de la présente loi peut être effectué en tout temps sur toute somme — notamment toute prestation payable au titre de la présente loi — à payer par Sa Majesté du chef du Canada à la personne, à l’exception de toute somme payable en vertu de l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Compensation et déduction

Acknowledgment of liability

(3) If a person’s liability for money owing under this Act is acknowledged in accordance with subsection (5), the time during which the limitation period has run before the acknowledgment does not count in the calculation of that period.
(3) Si, conformément au paragraphe (5), il est reconnu qu’une personne est responsable d’une créance exigible au titre de la présente loi, la période courue avant cette reconnaissance ne compte pas dans le calcul du délai de prescription.
Reconnaissance de responsabilité

Acknowledgment after expiry of limitation period

(4) If a person’s liability for money owing under this Act is acknowledged in accordance with subsection (5) after the expiry of the limitation period, an action or proceedings to recover the money may, subject to subsections (3) and (6), be brought within six years after the date of the acknowledgment.
(4) Si, après l’expiration du délai de prescription, il est reconnu, conformément au paragraphe (5), qu’une personne est responsable d’une créance exigible au titre de la présente loi, des poursuites en recouvrement peuvent être intentées, sous réserve des paragraphes (3) et (6), dans les six ans suivant la date de la reconnaissance de responsabilité.
Reconnaissance de responsabilité après l’expiration du délai de prescription

Types of acknowledgments

(5) An acknowledgment of liability means

(a) a written promise to pay the money owing, signed by the person or his or her agent or other representative;

(b) a written acknowledgment of the money owing, signed by the person or his or her agent or other representative, whether or not a promise to pay can be implied from it and whether or not it contains a refusal to pay;

(c) a part payment by the person or his or her agent or other representative of any money owing; or

(d) any acknowledgment of the money owing made by the person, his or her agent or other representative or the trustee or administrator in the course of proceedings under the Bankruptcy and Insolvency Act or any other legislation dealing with the payment of debts.
(5) Constituent une reconnaissance de responsabilité :
Types de reconnaissance de responsabilité

a) la promesse écrite de payer la créance exigible, signée par la personne ou par son mandataire ou autre représentant;

b) la reconnaissance écrite de l’exigibilité de la créance, signée par la personne ou par son mandataire ou autre représentant, que celle-ci contienne ou non une promesse implicite de payer ou une déclaration de refus de paiement;

c) le paiement partiel de la créance exigible par la personne ou par son mandataire ou autre représentant;

d) la reconnaissance par la personne, son mandataire ou autre représentant, le syndic ou l’administrateur de l’exigibilité de la créance, dans le cadre de mesures prises conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou dans le cadre de toute autre loi relative au paiement de dettes.

Limitation period suspended

(6) The running of a limitation period in respect of money owing under this Act is suspended during any period in which it is prohibited to commence or continue an action or other proceedings against the person to recover money owing under this Act.
(6) La prescription ne court pas pendant la période au cours de laquelle il est interdit d’intenter ou de continuer contre la personne des poursuites en recouvrement d’une créance exigible au titre de la présente loi.
Suspension du délai de prescription

Enforcement proceedings

(7) This section does not apply in respect of an action or proceedings relating to the execution, renewal or enforcement of a judgment.
(7) Le présent article ne s’applique pas à des poursuites relatives à l’exécution, à la mise en oeuvre ou au renouvellement d’une décision judiciaire.
Mise en oeuvre de décisions judiciaires

No interest payable

8. No interest is payable on any amount owing to Her Majesty under this Act as a result of an overpayment or an erroneous payment.
8. Les créances de Sa Majesté à l’égard des sommes versées indûment ou en excédent au titre de la présente loi ne portent pas intérêts.
Intérêts

Authority to enter agreements

9. The Minister may enter into agreements or arrangements with any department, board or agency of the Government of Canada to assist the Minister in carrying out the purposes and provisions of this Act.
9. Le ministre peut conclure des accords ou des ententes avec les ministères ou organismes fédéraux en vue de faciliter l’application de la présente loi.
Accords et ententes

Payment out of C.R.F.

10. All amounts payable by the Minister under section 4 shall be paid out of the Consolidated Revenue Fund.
10. Les sommes versées par le ministre aux termes de l’article 4 sont prélevées sur le Trésor.
Sommes prélevées sur le Trésor

Consequential And Related Amendments
Modifications corrélatives et connexes
1992, c. 48, Sch.

Children’s Special Allowances Act
Loi sur les allocations spéciales pour enfants
1992, ch. 48, ann.

169. The Children’s Special Allowances Act is amended by adding the following after section 2:
169. La Loi sur les allocations spéciales pour enfants est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Interpretation

2.1 (1) Except for the purposes of sections 2, 3, 3.1 and 8, the expression “special allowance” is to be read as including the special allowance supplement described in section 3.1.
2.1 (1) Sauf pour l’application des articles 2, 3, 3.1 et 8, l’allocation spéciale comprend le supplément visé à l’article 3.1.
Interprétation

Interpretation

(2) For the purposes of the payment of a special allowance supplement under section 3.1, the reference to “January 1993” in paragraph 4(2)(c) is to be read as a reference to “July 2006”.
(2) En ce qui concerne le service du supplément visé à l’article 3.1, la mention « janvier 1993 » au paragraphe 4(2) vaut mention de « juillet 2006 ».
Interprétation

170. The Act is amended by adding the following after section 3:
170. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
Monthly special allowance supplement

3.1 If a special allowance is payable under section 3 for a child under the age of six, there shall be added to that special allowance a special allowance supplement in the amount of $100 to be paid out of the Consolidated Revenue Fund.
3.1 Est ajouté à l’allocation spéciale mensuelle versée en vertu de l’article 3 pour un enfant âgé de moins de six ans un supplément de 100 $, prélevé sur le Trésor.
Versement mensuel — supplément

171. Paragraph 4(4)(d) of the Act is replaced by the following:
171. L’alinéa 4(4)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) reaches eighteen years of age or, in the case of a special allowance supplement paid under section 3.1, reaches six years of age.
d) atteint l’âge de dix-huit ans ou, dans le cas du supplément versé en vertu de l’article 3.1, l’âge de six ans.
1996, c. 23

Employment Insurance Act
Loi sur l’assurance-emploi
1996, ch. 23

172. The definition “income” in section 144 of the Employment Insurance Act is replaced by the following:
172. La définition de « revenu », à l’article 144 de la Loi sur l’assurance-emploi, est remplacée par ce qui suit :
“income”
« revenu »

“income” of a person for a period means the amount that would be their income for the period determined under the Income Tax Act if no amount were

(a) deductible under paragraphs 60(v.1), (w) and (y) of that Act,

(b) included in respect of a gain from a disposition of property to which section 79 of that Act applies, or

(c) included under subsection 56(6) of that Act;
« revenu » Le montant qui serait le revenu d’une personne pour une période, déterminé en application de la Loi de l’impôt sur le revenu, si aucun montant n’était déductible selon les alinéas 60v.1), w), et y) de cette loi, ni inclus au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien auquel l’article 79 de la même loi s’applique ou au titre du paragraphe 56(6) de la même loi.
« revenu »
income

R.S., c. 1 (5th Supp.)

Income Tax Act
Loi de l’impôt sur le revenu
L.R., ch. 1 (5e suppl.)

173. (1) Section 56 of the Income Tax Act is amended by adding the following after subsection (5):
173. (1) L’article 56 de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Child care benefit

(6) There shall be included in computing the income of a taxpayer for a taxation year the total of all amounts each of which is a benefit paid under section 4 of the Universal Child Care Benefit Act that is received in the taxation year by

(a) the taxpayer, if

(i) the taxpayer does not have a spouse or common-law partner at the end of the year, or

(ii) the income, for the taxation year, of the person who is the taxpayer’s spouse or common-law partner at the end of the taxation year is equal to or greater than the income of the taxpayer for the taxation year; or

(b) the taxpayer’s spouse or common-law partner at the end of the taxation year, if the income of the spouse or common-law partner for the taxation year is greater than the taxpayer’s income for the taxation year.
(6) Est inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition le total des sommes représentant chacune une prestation versée aux termes de l’article 4 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants que reçoit, au cours de l’année :
Prestation universelle pour la garde d’enfants

a) le contribuable, si :

(i) il n’a pas d’époux ou de conjoint de fait à la fin de l’année,

(ii) le revenu pour l’année de la personne qui est son époux ou conjoint de fait à la fin de l’année est égal ou supérieur au sien pour l’année;

b) l’époux ou le conjoint de fait du contribuable à la fin de l’année, si son revenu pour l’année est supérieur à celui du contribuable pour l’année.

(2) Subsection (1) applies to amounts received after June 30, 2006.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux sommes reçues après juin 2006.
174. (1) Section 60 of the Act is amended by striking out the word “and” at the end of paragraph (w), by adding the word “and” at the end of paragraph (x) and by adding the following after paragraph (x):
174. (1) L’article 60 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa x), de ce qui suit :
Repayment of UCCB

(y) the total of all amounts each of which is an amount paid in the taxation year as a repayment, under the Universal Child Care Benefit Act, of a benefit that was included because of subsection 56(6) in computing the taxpayer’s income for the taxation year or a preceding taxation year.
y) le total des sommes représentant chacune une somme versée au cours de l’année au titre du remboursement, prévu par la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants, d’une prestation qui a été incluse par l’effet du paragraphe 56(6) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.
Remboursement de la prestation universelle pour la garde d’enfants

(2) Subsection (1) applies to repayments made after June 30, 2006.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux remboursements effectués après juin 2006.
175. (1) The definition “adjusted income” in subsection 122.5(1) of the Act is replaced by the following:
175. (1) La définition de « revenu rajusté », au paragraphe 122.5(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“adjusted income”
« revenu rajusté »

“adjusted income” of an individual, for a taxation year in relation to a month specified for the taxation year, means the total of the individual’s income for the taxation year and the income for the taxation year of the individual’s qualified relation, if any, in relation to the specified month, both calculated as if no amount were included under subsection 56(6) or in respect of any gain from a disposition of property to which section 79 applies in computing that income and as if no amount were deductible under paragraph 60(y) in computing that income.
« revenu rajusté » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition par rapport à un mois déterminé de l’année, le total de son revenu pour l’année et du revenu pour l’année de son proche admissible par rapport à ce mois, calculés chacun comme si, dans le calcul de ce revenu, aucune somme n’était incluse en application du paragraphe 56(6) ou au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79 et aucune somme n’était déductible en application de l’alinéa 60y).
« revenu rajusté »
adjusted income

(2) Subsection (1) applies to the 2006 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.
176. (1) The definition “adjusted income” in section 122.6 of the Act is replaced by the following:
176. (1) La définition de « revenu modifié », à l’article 122.6 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“adjusted income”
« revenu modifié »

“adjusted income” of an individual for a taxation year means the total of all amounts each of which would be the income for the year of the individual or of the person who was the individual’s cohabiting spouse or common-law partner at the end of the year if no amount were included under subsection 56(6) or in respect of any gain from a disposition of property to which section 79 applies in computing that income and if no amount were deductible under paragraph 60(y) in computing that income;
« revenu modifié » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, le total des sommes qui représenteraient chacune le revenu pour l’année du particulier ou de la personne qui était son époux ou conjoint de fait visé à la fin de l’année si, dans le calcul de ce revenu, aucune somme n’était incluse en application du paragraphe 56(6) ou au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79 et aucune somme n’était déductible en application de l’alinéa 60y).
« revenu modifié »
adjusted income

(2) Subsection (1) applies to the 2006 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.
177. (1) The description of A in subsection 122.61(1) of the Act is amended by adding the word “and” at the end of paragraph (a), by striking out the word “and” at the end of paragraph (b) and by repealing paragraph (c).
177. (1) L’alinéa c) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la même loi est abrogé.
(2) Subsection (1) applies in respect of overpayments that are deemed to arise during months that are after June 2007, and, for overpayments that are deemed to arise during months that are after June 2006 and before July 2007, the description of D in subsection 122.61(1) of the Act is to be read as follows:
D      is the product obtained by multiplying $249 by the number of qualified dependants who have attained the age of 6 years before the month and have not attained the age of 7 years before the month and in respect of whom the person is an eligible individual at the beginning of the month, and
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux paiements en trop qui sont réputés se produire au cours des mois postérieurs à juin 2007. En ce qui concerne les paiements en trop qui sont réputés se produire au cours des mois postérieurs à juin 2006 et antérieurs à juillet 2007, l’élément D de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la même loi est réputé avoir le libellé suivant :
D      représente le produit de 249 $ par le nombre de personnes à charge admissibles qui ont atteint l’âge de 6 ans, mais non l’âge de 7 ans, avant le mois, à l’égard desquelles la personne est un particulier admissible au début du mois,
178. (1) The definition “adjusted income” in subsection 180.2(1) of the Act is replaced by the following:
178. (1) La définition de « revenu modifié », au paragraphe 180.2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“adjusted income”
« revenu modifié »

“adjusted income” of an individual for a taxation year means the amount that would be the individual’s income under Part I for the year if no amount were included under subsection 56(6) or in respect of a gain from a disposition of property to which section 79 applies in computing that income and if no amount were deductible under paragraph 60(w) or (y) in computing that income;
« revenu modifié » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, la somme qui représenterait son revenu en vertu de la partie I pour l’année si, dans le calcul de ce revenu, aucune somme n’était incluse en application du paragraphe 56(6) ou au titre d’un gain tiré de la disposition d’un bien auquel s’applique l’article 79 et aucune somme n’était déductible en application des alinéas 60w) ou y).
« revenu modifié »
adjusted income

(2) Subsection (1) applies to the 2006 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.
179. (1) Paragraph 241(4)(d) of the Act is amended by adding the following after subparagraph (vii.2):
179. (1) L’alinéa 241(4)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii.2), de ce qui suit :
(vii.3) to an official solely for the purposes of the administration and enforcement of the Children’s Special Allowances Act or the evaluation or formation of policy for that Act,
(vii.4) to an official solely for the purposes of the administration and enforcement of the Universal Child Care Benefit Act or the evaluation or formation of policy for that Act,
(vii.3) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants, ou en vue de l’évaluation ou de la formation de la politique concernant cette loi,
(vii.4) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants, ou en vue de l’évaluation ou de la formation de la politique concernant cette loi,
(2) Subparagraph 241(4)(d)(vii.3) of the Act, as enacted by subsection (1), applies after June 2003.
(2) Le sous-alinéa 241(4)d)(vii.3) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique à compter de juillet 2003.
(3) Subparagraph 241(4)(d)(vii.4) of the Act, as enacted by subsection (1), applies after June 2006.
(3) Le sous-alinéa 241(4)d)(vii.4) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique à compter de juillet 2006.
R.S., O-9

Old Age Security Act
Loi sur la sécurité de la vieillesse
L.R., ch. O-9

180. The definition “income” in section 2 of the Old Age Security Act is amended by striking out the word “and” at the end of paragraph (c), by adding the word “and” at the end of paragraph (d) and by adding the following after paragraph (d):
180. La définition de « revenu », à l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(e) there shall be deducted from the person’s income for the year any amount included under subsection 56(6) of the Income Tax Act and there shall be included in the person’s income for the year any amount that may be deducted under paragraph 60(y) of that Act;
e) est déduit du revenu de la personne pour l’année tout montant inclus au titre du paragraphe 56(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu et est inclus dans son revenu pour l’année tout montant déductible au titre de l’alinéa 60y) de cette loi.
Coming Into Force
Entrée en vigueur
Coming into force

181. This Part, other than sections 173 to 179, comes into force, or is deemed to have come into force, on July 1, 2006.
181. La présente partie, à l’exception des articles 173 à 179, entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le 1er juillet 2006.
Entrée en vigueur

PART 7
PARTIE 7
R.S., c. F-8; 1995, c. 17, s. 45(1)

AMENDMENTS TO THE FEDERAL-PROVINCIAL FISCAL ARRANGEMENTS ACT
MODIFICATION DE LA LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES
L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)

2005, c. 7, s. 1(1)

182. Section 3 of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act is replaced by the following:
182. L’article 3 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 7, par. 1(1)

Fiscal equalization payment

3. Subject to the provisions of this Act, there may be paid to a province for each fiscal year that begins after March 31, 2004 a fiscal equalization payment not exceeding the amounts set out in this Part.
3. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, un paiement de péréquation n’excédant pas les montants prévus par la présente partie peut être versé à une province pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2004.
Paiement de péréquation

2005, c. 7, s. 1(1)

183. (1) Subsection 4.1(3) of the Act is replaced by the following:
183. (1) Le paragraphe 4.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 7, par. 1(1)

Provincial allocation for fiscal year 2006-2007

(2.1) The fiscal equalization payment referred to in paragraph (1)(b) shall be allocated to the provinces as follows:

(a) to Quebec, $5,539,296,000;

(b) to Nova Scotia, $1,385,539,000;

(c) to New Brunswick, $1,450,799,000;

(d) to Manitoba, $1,709,430,000;

(e) to British Columbia, $260,228,000;

(f) to Prince Edward Island, $291,262,000;

(g) to Saskatchewan, $12,723,000; and

(h) to Newfoundland and Labrador, $632,223,000.
(2.1) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le paiement de péréquation à verser aux provinces ci-après est celui figurant en regard de leur nom :
Parts des provinces — exercice 2006-2007

a) Québec : 5 539 296 000 $;

b) Nouvelle-Écosse : 1 385 539 000 $;

c) Nouveau-Brunswick : 1 450 799 000 $;

d) Manitoba : 1 709 430 000 $;

e) Colombie-Britannique : 260 228 000 $;

f) Île-du-Prince-Édouard : 291 262 000 $;

g) Saskatchewan : 12 723 000 $;

h) Terre-Neuve-et-Labrador : 632 223 000 $.

Provincial allocation for subsequent fiscal years

(3) With the approval of the Governor in Council, the fiscal equalization payments referred to in paragraph (1)(c) shall be allocated to each province in the proportion that the Minister considers appropriate. The approval of the Governor in Council shall be given once in respect of the three-month period beginning on April 1, 2007 and once in respect of each subsequent three-month period, within three months before the beginning of each of those periods.
(3) Les paiements de péréquation visés à l’alinéa (1)c) sont répartis entre les provinces suivant la part respective de chacune, telle qu’elle est déterminée par le ministre et approuvée par le gouverneur en conseil. L’approbation du gouverneur en conseil est donnée une fois pour la période de trois mois qui commence au 1er avril 2007 ainsi que pour chaque période ultérieure de trois mois, et ce, au cours des trois mois précédant chacune de ces périodes.
Parts des provinces — exercices ultérieurs

2005, c. 7, s. 1(1)

(2) Subsection 4.1(4) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 4.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 7, par. 1(1)

Upward adjustment of fiscal equalization payment for the fiscal year 2006-2007

(3.1) If the fiscal equalization payment for the fiscal year beginning on April 1, 2006 to which a province is entitled under subsection (2.1) exceeds the fiscal equalization payment that was paid to that province in accordance with the allocation determined under subsection (3), as it read on April 1, 2006, an amount equal to the difference may be paid to the province at the times and in the manner that the Minister considers appropriate.
(3.1) Si le paiement de péréquation à verser à une province aux termes du paragraphe (2.1) pour l’exercice commençant le 1er avril 2006 est supérieur au paiement de péréquation que cette province a reçu suivant la répartition effectuée au titre du paragraphe (3), dans sa version au 1er avril 2006, une somme égale à la différence peut être versée à cette province, selon les échéances et les modalités que le ministre juge indiquées.
Révision à la hausse pour l’exercice 2006-2007

Overpayment made to a province for the fiscal year 2006-2007

(3.2) If the fiscal equalization payment for the fiscal year beginning on April 1, 2006 to which a province is entitled under subsection (2.1) is less than the fiscal equalization payment that was paid to that province in accordance with the allocation determined under subsection (3), as it read on April 1, 2006, the Minister may recover the amount of that overpayment

(a) from any amount payable to the province under this Act in that fiscal year or as soon as possible after the end of that fiscal year; or

(b) from the province as a debt due to Her Majesty in right of Canada.
(3.2) Si le paiement de péréquation à verser à une province aux termes du paragraphe (2.1) pour l’exercice commençant le 1er avril 2006 est inférieur au paiement de péréquation que cette province a reçu suivant la répartition effectuée au titre du paragraphe (3), dans sa version au 1er avril 2006, le ministre peut recouvrer la somme qui a été versée en trop, selon le cas :
Paiement en trop pour l’exercice 2006-2007

a) sur la somme à payer à la province en vertu de la présente loi au cours de cet exercice ou dès que possible après la fin de celui-ci;

b) auprès de la province à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.

Time and manner of payment

(4) The fiscal equalization payment shall be paid to the province in equal monthly instalments on the first and third working days after the 15th day of each month during the relevant fiscal year. For the purpose of this subsection, “working day” includes any day that is not a Saturday or a holiday.
(4) Le paiement de péréquation est versé à la province, en versements mensuels égaux, les premier et troisième jours ouvrables suivant le quinzième jour de chaque mois de l’exercice en cause, les jours fériés et les samedis n’étant pas des jours ouvrables.
Modalités de paiement

184. The Act is amended by adding the following after section 4.3:
184. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4.3, de ce qui suit :
Additional fiscal equalization payment for fiscal year 2006-2007

4.31 Despite paragraph 4.1(1)(b), an additional fiscal equalization payment for the fiscal year beginning on April 1, 2006, which shall not be included in the calculation made under paragraph 4.1(1)(c), may be paid, in accordance with subsection 4.1(4),

(a) to British Columbia, in the amount of $199,184,000; and

(b) to Newfoundland and Labrador, in the amount of $54,380,000.
4.31 Malgré l’alinéa 4.1(1)b), le paiement de péréquation supplémentaire figurant en regard du nom d’une des provinces ci-après peut être versé à cette province pour l’exercice commençant le 1er avril 2006, conformément au paragraphe 4.1(4), ce paiement étant alors exclu du calcul visé à l’alinéa 4.1(1)c) :
Paiement de péréquation supplémentaire pour l’exercice 2006-2007

a) Colombie-Britannique : 199 184 000 $;

b) Terre-Neuve-et-Labrador : 54 380 000 $.

2005, c. 7, s. 1(1)

185. The portion of section 4.4 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
185. Le passage de l’article 4.4 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 7, par. 1(1)

Payments to territories

4.4 Subject to the provisions of this Part, there may be paid to a territory
4.4 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, peuvent être versés à un territoire :
Paiements aux territoires

186. (1) Section 4.92 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
186. (1) L’article 4.92 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Payment for fiscal year 2006-2007

(1.1) For the fiscal year beginning on April 1, 2006, a territorial formula financing payment may be paid

(a) to Yukon, in the amount of $505,608,000;

(b) to the Northwest Territories, in the amount of $739,414,000; and

(c) to Nunavut, in the amount of $824,978,000.
(1.1) Pour l’exercice commençant le 1er avril 2006, le paiement de transfert figurant en regard du nom d’un des territoires ci-après peut être versé à ce territoire :
Paiement — exercice 2006-2007

a) Yukon : 505 608 000 $;

b) Territoires du Nord-Ouest : 739 414 000 $;

c) Nunavut : 824 978 000 $.

2005, c. 7, s. 1(1)

(2) Subsections 4.92(3) and (4) of the Act are replaced by the following:
(2) Les paragraphes 4.92(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2005, ch. 7, par. 1(1)

Territorial allocation for subsequent fiscal years

(3) With the approval of the Governor in Council, the territorial formula financing payments referred to in subsection (2) shall be allocated to each territory in the proportion that the Minister considers appropriate. The approval of the Governor in Council shall be given once in respect of the three-month period beginning on April 1, 2007 and once in respect of each subsequent three-month period, within three months before the beginning of each of those periods.
(3) Les paiements de transfert visés au paragraphe (2) sont répartis entre les territoires suivant la part respective de chacun, telle qu’elle est déterminée par le ministre et approuvée par le gouverneur en conseil. L’approbation du gouverneur en conseil est donnée une fois pour la période de trois mois qui commence au 1er avril 2007 ainsi que pour chaque période ultérieure de trois mois, et ce, au cours des trois mois précédant chacune de ces périodes.
Parts des territoires — exercices ultérieurs

Time and manner of payment

(4) In April and May of each fiscal year beginning after March 31, 2005, there shall be paid to a territory a monthly instalment of the territorial formula financing payment equal to 16 per cent of the territory’s allocation of the aggregate territorial formula financing payment for that fiscal year. In each of the remaining ten months of the fiscal year, there shall be paid to the territory a monthly instalment of the territorial formula financing payment equal to 6.8 per cent of the territory’s allocation of the aggregate territorial formula financing payment under this section.
(4) En avril et en mai de chaque exercice commençant après le 31 mars 2005, un acompte mensuel égal à 16 % de la part du paiement de transfert d’un territoire pour l’exercice est versé à ce territoire. Au cours des autres mois de l’exercice, un acompte mensuel égal à 6,8 % de la part de ce paiement est versé au territoire.
Calendrier et modalités des paiements

2005, c. 7, s. 1(1)

187. Section 4.93 of the Act is replaced by the following:
187. L’article 4.93 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 7, par. 1(1)

Underpayment

4.93 (1) If it is determined that an underpayment of any amounts payable to a territory under section 4.92 has been made, an amount equal to the underpayment may be paid to the territory at the times and in the manner that the Minister considers appropriate.
4.93 (1) S’il est établi qu’une somme à payer au titre de l’article 4.92 n’a pas été versée à un territoire, une somme égale au moins-perçu peut être payée, selon les échéances et les modalités que le ministre juge indiquées.
Paiement insuffisant

Overpayment

(2) If it is determined that an overpayment in respect of any amounts payable to a territory under section 4.92 for a fiscal year has been made, the Minister may recover the amount of that overpayment

(a) from any amount payable to the territory under this Act in the same fiscal year or as soon as possible after the end of that fiscal year; or

(b) from the territory as a debt due to Her Majesty in right of Canada.
(2) S’il est établi que, pour un exercice, une somme a été versée en trop à un territoire au titre de l’article 4.92, le ministre peut la recouvrer, selon le cas :
Paiement en trop

a) sur la somme à payer au territoire en vertu de la présente loi au cours du même exercice ou dès que possible après la fin de celui-ci;

b) auprès du territoire à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.

188. The Act is amended by adding the following after section 4.93:
188. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4.93, de ce qui suit :
Additional territorial formula financing payment for fiscal year 2006-2007

4.94 Despite subsection 4.92(1.1), an additional territorial formula financing payment for the fiscal year beginning on April 1, 2006, which shall not be included in the calculation made under subsection 4.92(2), may be paid, in accordance with subsection 4.92(4),

(a) to Yukon, in the amount of $311,000; and

(b) to Nunavut, in the amount of $1,553,000.
4.94 Malgré le paragraphe 4.92(1.1), le paiement de transfert supplémentaire figurant en regard du nom d’un des territoires ci-après peut être versé à ce territoire pour l’exercice commençant le 1er avril 2006, conformément au paragraphe 4.92(4), ce paiement étant alors exclu du calcul visé au paragraphe 4.92(2) :
Paiement de transfert supplémentaire pour l’exercice 2006-2007

a) Yukon : 311 000 $;

b) Nunavut : 1 553 000 $.

2005, c. 7, s. 6

189. Section 41 of the Act is replaced by the following:
189. L’article 41 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 7, art. 6

Payment out of C.R.F.

41. From and out of the Consolidated Revenue Fund there may, on the requisition of the Minister, be paid an amount authorized to be paid by Part I, I.1 or II at the times and in the manner that may be prescribed or, if no times and manner have been prescribed, at the times and in the manner set out in that Part.
41. À la demande du ministre, peuvent être prélevées sur le Trésor les sommes dont le versement est autorisé par les parties I, I.1 ou II, selon les échéances et les modalités prescrites ou, en l’absence de règlements, selon les échéances et les modalités prévues dans ces parties.
Paiement sur le Trésor

PART 8
PARTIE 8
PAYMENTS TO PROVINCES AND TERRITORIES
PAIEMENTS AUX PROVINCES ET AUX TERRITOIRES
Payment of $650,000,000

190. (1) From and out of the Consolidated Revenue Fund, there may, on the requisition of the Minister of Human Resources and Skills Development, be paid to the provinces a payment in the amount of $650,000,000 for the fiscal year beginning on April 1, 2006, in respect of early learning and child care.
190. (1) À la demande du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, peut être prélevée sur le Trésor et affectée aux provinces, pour l’exercice commençant le 1er avril 2006, une somme de 650 000 000 $ pour le développement de la petite enfance et la garde d’enfants.
Paiement de 650 000 000 $

Provincial allocation

(2) The payment referred to in subsection (1) shall be allocated to the provinces as follows:

(a) to Ontario, $252,933,933.35;

(b) to Quebec, $152,740,663.90;

(c) to Nova Scotia, $18,743,350.65;

(d) to New Brunswick, $15,028,068.42;

(e) to Manitoba, $23,683,368.44;

(f) to British Columbia, $85,920,064.72;

(g) to Prince Edward Island, $2,762,632.45;

(h) to Saskatchewan, $19,863,918.85;

(i) to Alberta, $65,973,415.33;

(j) to Newfoundland and Labrador, $10,266,477.67;

(k) to Yukon, $619,370.20;

(l) to the Northwest Territories, $862,067.75; and

(m) to Nunavut, $602,668.27.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la somme à payer aux provinces est celle figurant ci-après en regard du nom de chacune :
Quote-part de chaque province

a) Ontario : 252 933 933,35 $;

b) Québec : 152 740 663,90 $;

c) Nouvelle-Écosse : 18 743 350,65 $;

d) Nouveau-Brunswick : 15 028 068,42 $;

e) Manitoba : 23 683 368,44 $;

f) Colombie-Britannique : 85 920 064,72 $;

g) Île-du-Prince-Édouard : 2 762 632,45 $;

h) Saskatchewan : 19 863 918,85 $;

i) Alberta : 65 973 415,33 $;

j) Terre-Neuve-et-Labrador : 10 266 477,67 $;

k) Yukon : 619 370,20 $;

l) Territoires du Nord-Ouest : 862 067,75 $;

m) Nunavut : 602 668,27 $.

Payment to territories

191. From and out of the Consolidated Revenue Fund, there may, on the requisition of the Minister of Finance, be paid to the territories the following payments for the fiscal year beginning on April 1, 2006:

(a) to Yukon, $10,900,000;

(b) to the Northwest Territories, $18,000,000; and

(c) to Nunavut, $17,500,000.
191. À la demande du ministre des Finances, peut être prélevée sur le Trésor et affectée aux territoires, pour l’exercice commençant le 1er avril 2006, la somme figurant ci-après en regard du nom de chacun :
Paiement aux territoires

a) Yukon : 10 900 000 $;

b) Territoires du Nord-Ouest : 18 000 000 $;

c) Nunavut : 17 500 000 $.

PART 9
PARTIE 9
MORTGAGE INSURANCE
ASSURANCE HYPOTHÉCAIRE
Interpretation

192. The following definitions apply in sections 193 and 194.
“mortgagee”
« créancier hypothécaire »

“mortgagee” means a mortgagee or hypothecary creditor that holds a mortgage or hypothec insurance policy with a mortgage insurer.
“mortgage insurer”
« assureur hypothécaire »

“mortgage insurer” means a corporation to which subsection 13(1) of the Insurance Companies Act applies and that is approved by the Superintendent of Financial Institutions to sell mortgage or hypothec insurance policies in Canada.
192. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 193 et 194.
Définitions

« assureur hypothécaire » Personne morale visée au paragraphe 13(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances que le surintendant des institutions financières a autorisée à vendre de l’assurance hypothécaire au Canada.
« assureur hypothécaire »
mortgage insurer

« créancier hypothécaire » Celui qui est titulaire d’une police d’assurance hypothécaire émise par un assureur hypothécaire.
« créancier hypothécaire »
mortgagee

Mortgage or hypothec insurance protection agreement

193. (1) The Minister of Finance may, with respect to an insurance policy held by a mortgagee, enter into an agreement with any person, including a mortgage insurer or the mortgagee, to do any of the following:

(a) provide an indemnity to the mortgagee;

(b) provide a guarantee or suretyship to the mortgagee; and

(c) purchase a replacement insurance policy for the mortgagee.
193. (1) Le ministre des Finances peut, relativement à la police d’assurance hypothécaire d’un créancier hypothécaire, conclure un accord avec quiconque, notamment un assureur hypothécaire ou le créancier hypothécaire, afin :
Accord

a) d’offrir une indemnisation au créancier hypothécaire;

b) de lui offrir un cautionnement;

c) d’aquérir une police d’assurance de remplacement pour son bénéfice.

Payment to be made

(2) The agreement shall provide that, if the mortgage insurer with whom the mortgagee holds an insurance policy becomes insolvent or is liquidated, a payment shall be made to the mortgagee, or to another mortgage insurer if the agreement provides for a replacement insurance policy.
(2) L’accord doit, en cas d’insolvabilité ou de liquidation de l’assureur hypothécaire qui a émis la police d’assurance au créancier hypothécaire, prévoir qu’une somme doit être payée à ce dernier ou, dans le cas d’une police d’assurance de remplacement, à tout autre assureur hypothécaire.
Paiement

Amount of payment

(3) Subject to regulations made under paragraph 194(1)(a), the payment shall be equal to the benefits payable under the insurance policy held with the mortgage insurer less 10 per cent of the original principal amount of the mortgage or hypothec that is subject to the insurance policy.
(3) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 194(1)a), le montant du paiement équivaut au total des prestations à payer en vertu de la police d’assurance émise par le créancier hypothécaire, duquel est soustrait le montant représentant dix pour cent du montant initial du principal de l’hypothèque qui fait l’objet de la police d’assurance.
Montant du paiement

Limitation

(4) The aggregate outstanding principal amount of all mortgages or hypothecs to which insurance policies that are subject to such agreements apply shall not at any time exceed $200,000,000,000 or any other amount that may be authorized for the purposes of this subsection under an appropriation Act.
(4) Le montant total du solde impayé du principal de toutes les hypothèques visées par une police d’assurance faisant l’objet d’un accord ne doit en aucun temps dépasser 200 000 000 000 $, ou tel autre montant établi pour l’application du présent paragraphe par une loi de crédits.
Montant total des accords

Deeming

(5) An agreement having the same purpose as an agreement referred to in subsection (1) and that is entered into by the Minister of Finance before the coming into force of that subsection is deemed to be an agreement referred to in this section.
(5) Un accord ayant le même objet que celui visé au paragraphe (1) et ayant été conclu par le ministre des Finances avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe est réputé être un accord visé au présent article.
Présomption

Regulations

194. (1) The Governor in Council may make regulations respecting

(a) the percentage of the original principal amount to be subtracted under subsection 193(3), including the mortgages or hypothecs to which that percentage applies;

(b) information and documents, electronic or otherwise, to be maintained by a person who is a party to an agreement referred to in section 193; and

(c) the disclosure of any information and documents, electronic or otherwise, by such a person to the Minister of Finance or any person designated by the Minister of Finance.
194. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :
Règlements

a) le pourcentage du montant initial du principal de l’hypothèque qui est soustrait au titre du paragraphe 193(3), notamment les hypothèques auxquelles ce pourcentage s’applique;

b) les renseignements et documents, électroniques ou autres, qui doivent être tenus par la personne qui est partie à un accord visé à l’article 193;

c) la communication par la personne qui est partie à un accord visé à l’article 193, au ministre des Finances ou à toute autre personne qu’il désigne, de renseignements et documents, électroniques ou autres.

Application of regulations

(2) A regulation made under paragraph (1)(a) does not apply in respect of a mortgage or hypothec that became insured before the coming into force of the regulation by an insurance policy that is subject to an agreement referred to in section 193.
(2) Le règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a) ne s’applique pas à l’égard de l’hypothèque assurée, avant l’entrée en vigueur du règlement, par une police d’assurance faisant l’objet d’un accord visé à l’article 193.
Non-rétroactivité

Amount to be paid out of C.R.F.

195. From and out of the Consolidated Revenue Fund there may, on the requisition of the Minister of Finance, be paid any amounts to be paid under an agreement entered into under section 193.
195. À la demande du ministre des Finances, peuvent être prélevées sur le Trésor les sommes à verser aux termes d’un accord visé à l’article 193.
Paiement sur le Trésor

2004, c. 1

196. Finance vote 16b of Appropriation Act No. 4, 2003-2004 is repealed.
196. Le crédit 16b (Finances) à la Loi de crédits no 4 pour 2003-2004 est abrogé.
2004, ch. 1

Appropriation Act No. 1, 2006-2007

197. If a bill entitled Appropriation Act No. 1, 2006-2007 is introduced in the first session of the 39th Parliament and receives royal assent, Finance vote 10 of that Act is repealed.
197. En cas de sanction du projet de loi intitulé Loi de crédits no 1 pour 2006-2007, déposé au cours de la première session de la 39e législature, le crédit 10 (Finances) à cette loi est abrogé.
Loi de crédits no 1 pour 2006-2007

Appropriation Act No. 1, 2006-2007

198. If a bill entitled Appropriation Act No. 1, 2006-2007 is introduced in the first session of the 39th Parliament and comes into force before section 196 of this Act, section 196 of this Act is repealed.
198. En cas d’entrée en vigueur du projet de loi intitulé Loi de crédits no 1 pour 2006-2007, déposé au cours de la première session de la 39e législature, avant celle de l’article 196 de la présente loi, l’article 196 de la présente loi est abrogé.
Loi de crédits no 1 pour 2006-2007

PART 10
PARTIE 10
AMENDMENTS RELATING TO FINANCIAL INSTITUTIONS
MODIFICATIONS RELATIVES AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES
1991, c. 46

Bank Act
Loi sur les banques
1991, ch. 46

2001, c. 9, s. 44

199. Subsection 21(1) of the Bank Act is replaced by the following:
199. Le paragraphe 21(1) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 44

Sunset provision

21. (1) Subject to subsection (2), banks shall not carry on business and authorized foreign banks shall not carry on business in Canada after April 24, 2007, except that if Parliament dissolves on that day or at any time within the three-month period before that day, banks may continue to carry on business, and authorized foreign banks may continue to carry on business in Canada, respectively, until the day that is one hundred and eighty days after the first day of the first session of the next Parliament.
21. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les banques ne peuvent exercer leurs activités ni les banques étrangères autorisées leurs activités au Canada après le 24 avril 2007; toutefois, si le Parlement est dissous à cette date ou au cours des trois mois qui précèdent, elles peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
Temporarisation

2001, c. 9, s. 183

199.1 Subsection 670(1) of the Act is replaced by the following:
199.1 Le paragraphe 670(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 183

Sunset provision

670. (1) Subject to subsection (2), bank holding companies shall not carry on business after April 24, 2007, except that if Parliament dissolves on that day or at any time within the three-month period before that day, bank holding companies may continue to carry on business until the day that is one hundred and eighty days after the first day of the first session of the next Parliament.
670. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les sociétés de portefeuille bancaires ne peuvent exercer leurs activités après le 24 avril 2007; toutefois, si le Parlement est dissous à cette date ou au cours des trois mois qui précèdent, elles peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
Temporarisation

1991, c. 48

Cooperative Credit Associations Act
Loi sur les associations coopératives de crédit
1991, ch. 48

2001, c. 9, s. 254

200. Subsection 22(1) of the Cooperative Credit Associations Act is replaced by the following:
200. Le paragraphe 22(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 254

Sunset provision

22. (1) Subject to subsection (2), associations shall not carry on business after April 24, 2007, except that if Parliament dissolves on that day or at any time within the three-month period before that day, associations may continue to carry on business until the day that is one hundred and eighty days after the first day of the first session of the next Parliament.
22. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les associations ne peuvent exercer leurs activités après le 24 avril 2007; toutefois, si le Parlement est dissous à cette date ou au cours des trois mois qui précèdent, elles peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
Temporarisation

1991, c. 47

Insurance Companies Act
Loi sur les sociétés d’assurances
1991, ch. 47

2001, c. 9, s. 353

201. Subsection 21(1) of the Insurance Companies Act is replaced by the following:
201. Le paragraphe 21(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 353

Sunset provision

21. (1) Subject to subsection (2), companies and societies shall not carry on business after April 24, 2007, except that if Parliament dissolves on that day or at any time within the three-month period before that day, companies and societies may continue to carry on business until the day that is one hundred and eighty days after the first day of the first session of the next Parliament.
21. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les sociétés ne peuvent exercer leurs activités après le 24 avril 2007; toutefois, si le Parlement est dissous à cette date ou au cours des trois mois qui précèdent, elles peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
Temporarisation

2001, c. 9, s. 465

201.1 Subsection 707(1) of the Act is replaced by the following:
201.1 Le paragraphe 707(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 465

Sunset provision

707. (1) Subject to subsection (2), insurance holding companies shall not carry on business after April 24, 2007, except that if Parliament dissolves on that day or at any time within the three-month period before that day, insurance holding companies may continue to carry on business until the day that is one hundred and eighty days after the first day of the first session of the next Parliament.
707. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les sociétés de portefeuille d’assurances ne peuvent exercer leurs activités après le 24 avril 2007; toutefois, si le Parlement est dissous à cette date ou au cours des trois mois qui précèdent, elles peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
Temporarisation

1991, c. 45

Trust and Loan Companies Act
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
1991, ch. 45

2001, c. 9, s. 484

202. Subsection 20(1) of the Trust and Loan Companies Act is replaced by the following:
202. Le paragraphe 20(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 484

Sunset provision

20. (1) Subject to subsection (2), companies shall not carry on business after April 24, 2007, except that if Parliament dissolves on that day or at any time within the three-month period before that day, companies may continue to carry on business until the day that is one hundred and eighty days after the first day of the first session of the next Parliament.
20. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les sociétés ne peuvent exercer leurs activités après le 24 avril 2007; toutefois, si le Parlement est dissous à cette date ou au cours des trois mois qui précèdent, elles peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
Temporarisation

PART 11
PARTIE 11
AMENDMENTS RELATING TO PENSIONS
MODIFICATIONS EN MATIÈRE DE PENSIONS
R.S., c. C-17

Canadian Forces Superannuation act
Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes
L.R., ch. C-17

203. Subsection 15(2) of the Canadian Forces Superannuation Act is replaced by the following:
203. Le paragraphe 15(2) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes est remplacé par ce qui suit :
Deduction from annuity

(2) Notwithstanding subsection (1), unless the Minister is satisfied that a contributor

(a) has not reached the age of sixty-five years, and

(b) has not become entitled to a disability pension payable under paragraph 44(1)(b) of the Canada Pension Plan or a provision of a provincial pension plan similar to the Canada Pension Plan,

there shall be deducted from the amount of any annuity to which that contributor is entitled under this Act an amount equal to the percentage, as set out in subsection (2.1), of

(c) the average annual pay received by the contributor during the period of pensionable service described in subsection (1) applicable to him or her, not exceeding his or her Average Maximum Pensionable Earnings,

multiplied by

(d) the number of years of pensionable service after 1965 or after he or she has attained the age of eighteen years, whichever is the later, to the credit of the contributor, not exceeding thirty-five, divided by fifty.
(2) Nonobstant le paragraphe (1), à moins que le ministre ne soit convaincu qu’un contributeur :
Déduction de la pension

a) d’une part, n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans;

b) d’autre part, n’a pas droit à une pension d’invalidité payable aux termes de l’alinéa 44(1)b) du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions analogue,

il est déduit du montant de toute pension à laquelle ce contributeur a droit en vertu de la présente partie un montant égal au pourcentage, prévu au paragraphe (2.1), du produit de la solde obtenue à l’alinéa c) par le nombre obtenu à l’alinéa d) :

c) la solde annuelle moyenne reçue par le contributeur pendant la période de service ouvrant droit à pension visée au paragraphe (1) qui lui est applicable, ne dépassant pas sa moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension;

d) le nombre d’années de service ouvrant droit à pension après 1965 ou après qu’il a atteint l’âge de dix-huit ans, en prenant des deux dates celle qui intervient la dernière, au crédit du contributeur, ne dépassant pas trente-cinq, divisé par cinquante.

Percentages

(2.1) For the purposes of subsection (2), the percentage that applies in respect of a contributor is

(a) 35%, if the contributor was born before 1943;

(b) 34.25%, if the contributor was born in 1943;

(c) 33.5%, if the contributor was born in 1944;

(d) 32.75% if the contributor was born in 1945;

(e) 32%, if the contributor was born in 1946; and

(f) 31.25%, if the contributor was born after 1946.
(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), le pourcentage est le suivant :
Pourcentages

a) trente-cinq pour cent si le contributeur est né avant 1943;

b) trente-quatre et un quart pour cent s’il est né en 1943;

c) trente-trois et demi pour cent s’il est né en 1944;

d) trente-deux et trois quarts pour cent s’il est né en 1945;

e) trente-deux pour cent s’il est né en 1946;

f) trente et un et un quart pour cent s’il est né après 1946.

R.S., c. P-36

Public Service Superannuation Act
Loi sur la pension de la fonction publique
L.R., ch. P-36

1992. c. 46, s. 1(2)

204. Subsection 3(4) of the Public Service Superannuation Act is replaced by the following:
204. Le paragraphe 3(4) de la Loi sur la pension de la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
1992, ch. 46, par. 1(2)

When specified age deemed to be reached

(4) For the purposes of paragraph 8(2)(e), a person is deemed to have reached the age of eighteen years at the beginning of the month following the month in which the person actually reached that age and, for the purposes of paragraph 11(2)(a), a person is deemed to have reached the age of sixty-five years at the beginning of the month following the month in which the person actually reached that age.
(4) Pour l’application de l’alinéa 8(2)e), une personne est réputée avoir atteint l’âge de dix-huit ans au début du mois qui suit celui au cours duquel elle a réellement atteint cet âge et, pour l’application de l’alinéa 11(2)a), elle est réputée avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans au début du mois qui suit celui au cours duquel elle a réellement atteint cet âge.
Âge donné réputé atteint

205. Subsection 11(2) of the Act is replaced by the following:
205. Le paragraphe 11(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Deduction from annuity

(2) Notwithstanding subsection (1), unless the Minister is satisfied that a contributor

(a) has not reached the age of sixty-five years, and

(b) has not become entitled to a disability pension payable under paragraph 44(1)(b) of the Canada Pension Plan or a provision of a provincial pension plan similar to the Canada Pension Plan,

there shall be deducted from the amount of any annuity to which that contributor is entitled under this Part an amount equal to the percentage, as set out in subsection (2.1), of

(c) the average annual salary received by the contributor during the period of pensionable service described in subsection (1) applicable to him or her, not exceeding his or her Average Maximum Pensionable Earnings,

multiplied by

(d) the number of years of pensionable service after 1965 to the credit of the contributor, not exceeding thirty-five, divided by fifty.
(2) Nonobstant le paragraphe (1), à moins que le ministre ne soit convaincu qu’un contributeur :
Déduction de la pension

a) d’une part, n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans;

b) d’autre part, n’a pas droit à une pension d’invalidité payable aux termes de l’alinéa 44(1)b) du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions analogue,

il est déduit du montant de toute pension à laquelle ce contributeur a droit en vertu de la présente partie un montant égal au pourcentage, prévu au paragraphe (2.1), du produit du traitement obtenu à l’alinéa c) par le nombre obtenu à l’alinéa d) :

c) le traitement annuel moyen reçu par le contributeur au cours de la période de service ouvrant droit à pension décrit au paragraphe (1) qui lui est applicable, n’excédant pas la moyenne des maximums de ses gains ouvrant droit à pension;

d) le nombre d’années de service ouvrant droit à pension, postérieures à 1965, au crédit du contributeur, n’excédant pas trente-cinq, divisé par cinquante.

Percentages

(2.1) For the purposes of subsection (2), the percentage that applies in respect of a contributor is

(a) 35%, if the contributor was born before 1943;

(b) 34.25%, if the contributor was born in 1943;

(c) 33.5%, if the contributor was born in 1944;

(d) 32.75% if the contributor was born in 1945;

(e) 32%, if the contributor was born in 1946; and

(f) 31.25%, if the contributor was born after 1946.
(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), le pourcentage est le suivant :
Pourcentages

a) trente-cinq pour cent si le contributeur est né avant 1943;

b) trente-quatre et un quart pour cent s’il est né en 1943;

c) trente-trois et demi pour cent s’il est né en 1944;

d) trente-deux et trois quarts pour cent s’il est né en 1945;

e) trente-deux pour cent s’il est né en 1946;

f) trente et un et un quart pour cent s’il est né après 1946.

R.S., c. R-11

Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act
Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
L.R., ch. R-11

206. Subsection 10(2) of the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act is replaced by the following:
206. Le paragraphe 10(2) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada est remplacé par ce qui suit :
Deduction from annuity

(2) Notwithstanding subsection (1), unless the Minister is satisfied that a contributor

(a) has not reached the age of sixty-five years, and

(b) has not become entitled to a disability pension payable under paragraph 44(1)(b) of the Canada Pension Plan or a provision of a provincial pension plan similar to the Canada Pension Plan,

there shall be deducted from the amount of any annuity to which that contributor is entitled under this Part an amount equal to the percentage, as set out in subsection (2.1), of

(c) the average annual pay received by the contributor during the period of pensionable service described in subsection (1) applicable to him or her, not exceeding his or her Average Maximum Pensionable Earnings,

multiplied by

(d) the number of years of pensionable service after 1965 or after he or she has attained the age of eighteen years, whichever is the later, to the credit of the contributor, not exceeding thirty-five, divided by fifty.
(2) Nonobstant le paragraphe (1), à moins que le ministre ne soit convaincu qu’un contributeur :
Déduction de la pension

a) d’une part, n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans;

b) d’autre part, n’a pas droit à une pension d’invalidité payable aux termes de l’alinéa 44(1)b) du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions analogue,

il est déduit du montant de toute pension à laquelle ce contributeur a droit en vertu de la présente partie un montant égal au pourcentage, prévu au paragraphe (2.1), du produit de la solde obtenue à l’alinéa c) par le nombre obtenu à l’alinéa d) :

c) la solde annuelle moyenne reçue par le contributeur pendant la période de service ouvrant droit à pension visée au paragraphe (1) qui lui est applicable, ne dépassant pas sa moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension;

d) le nombre d’années de service ouvrant droit à pension après 1965 ou après qu’il a atteint l’âge de dix-huit ans, en prenant des deux dates celle qui intervient la dernière, au crédit du contributeur, ne dépassant pas trente-cinq, divisé par cinquante.

Percentages

(2.1) For the purposes of subsection (2), the percentage that applies in respect of a contributor is

(a) 35%, if the contributor was born before 1943;

(b) 34.25%, if the contributor was born in 1943;

(c) 33.5%, if the contributor was born in 1944;

(d) 32.75% if the contributor was born in 1945;

(e) 32%, if the contributor was born in 1946; and

(f) 31.25%, if the contributor was born after 1946.
(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), le pourcentage est le suivant :
Pourcentages

a) trente-cinq pour cent si le contributeur est né avant 1943;

b) trente-quatre et un quart pour cent s’il est né en 1943;

c) trente-trois et demi pour cent s’il est né en 1944;

d) trente-deux et trois quarts pour cent s’il est né en 1945;

e) trente-deux pour cent s’il est né en 1946;

f) trente et un et un quart pour cent s’il est né après 1946.

Coming into Force
Entrée en vigueur
Coming into force

207. This Part comes into force on January 1, 2008.
207. La présente partie entre en vigueur le 1er janvier 2008.
Entrée en vigueur

PART 12
PARTIE 12
MACKENZIE GAS PROJECT IMPACTS ACT
LOI RELATIVE AUX RÉPERCUSSIONS DU PROJET GAZIER MACKENZIE
Enactment of Act
Édiction de la Loi
Enactment of Act

208. The Mackenzie Gas Project Impacts Act, whose text is as follows and whose schedule is set out in Schedule 2 to this Act, is hereby enacted:
208. Est édictée la Loi relative aux répercussions du projet gazier Mackenzie dont le texte suit et dont l’annexe figure à l’annexe 2 de la présente loi.
Édiction de la Loi

An Act to establish the Corporation for the Mitigation of Mackenzie Gas Project Impacts
Loi constituant la Société d’atténuation des répercussions du projet gazier Mackenzie
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Mackenzie Gas Project Impacts Act.
1. Loi relative aux répercussions du projet gazier Mackenzie.
Titre abrégé

INTERPRETATION
DÉFINITIONS
Definitions

2. The following definitions apply in this Act.
“board”
« conseil »

“board” means the board of directors of the Corporation.
“Corporation”
« Société »

“Corporation” means the Corporation for the Mitigation of Mackenzie Gas Project Impacts established by section 3.
“director”
« administrateur »

“director” means a person who is on the board and includes the chairperson.
“eligible project”
« travaux admissibles »

“eligible project” means a project referred to in section 5.
“employee or agent of Her Majesty in right of a province”
« fonctionnaire ou mandataire de Sa Majesté du chef d’une province »

“employee or agent of Her Majesty in right of a province” does not include an employee or agent of Her Majesty in right of a province whose duties and functions in that capacity are restricted to work in a university, college or other educational institution.
“Mackenzie gas project”
« projet gazier Mackenzie »

“Mackenzie gas project” means the project proposed by a consortium led by Imperial Oil Resources Ventures Limited that includes the development of the natural gas fields of Niglintgak, Taglu and Parsons Lake, and the construction and operation of

(a) a gathering system related to those fields;

(b) a natural gas liquids pipeline;

(c) the natural gas pipeline that is the subject of the application GH-12004 made to the National Energy Board on October 7, 2004; and

(d) facilities related to the fields, the gathering system or the pipelines.
“Minister”
« ministre »

“Minister” means the Minister of Indian Affairs and Northern Development.
“regional organization”
« organisation régionale »

“regional organization” means an organization referred to in the schedule.
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Définitions

« administrateur » Personne qui siège au conseil, y compris le président.
« administrateur »
director

« conseil » Le conseil d’administration de la Société.
« conseil »
board

« fonctionnaire ou mandataire de Sa Majesté du chef d’une province » N’est pas un fonctionnaire ou mandataire de Sa Majesté du chef d’une province celui qui exerce des fonctions à ce titre uniquement dans une université, un collège ou un autre établissement d’enseignement.
« fonctionnaire ou mandataire de Sa Majesté du chef d’une province »
employee or agent of Her Majesty in right of a province

« ministre » Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.
« ministre »
Minister

« organisation régionale » Organisation dont le nom figure à l’annexe.
« organisation régionale »
regional organization

« projet gazier Mackenzie » Le projet proposé par un consortium mené par Imperial Oil Resources Ventures Limited qui comprend l’exploitation des gisements de gaz naturel de Niglintgak, Taglu et Parsons Lake ainsi que la construction et l’exploitation :
« projet gazier Mackenzie »
Mackenzie gas project

a) d’un réseau de collecte relatif à ces gisements;

b) d’un oléoduc servant à acheminer les composantes liquides du gaz naturel;

c) du gazoduc faisant l’objet de la demande numéro GH-12004 qui a été présentée à l’Office national de l’énergie le 7 octobre 2004;

d) de toute installation relative au réseau, à l’oléoduc ou au gazoduc.

« Société » La Société d’atténuation des répercussions du projet gazier Mackenzie constituée par l’article 3.
« Société »
Corporation

« travaux admissibles » Travaux visés à l’article 5.
« travaux admissibles »
eligible project

INCORPORATION
CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ
Corporation established

3. There is hereby established a corporation to be known as the Corporation for the Mitigation of Mackenzie Gas Project Impacts.
3. Est constituée la Société d’atténuation des répercussions du projet gazier Mackenzie.
Constitution

Corporation not agent of Her Majesty

4. The Corporation is not an agent of Her Majesty in right of Canada.
4. La Société n’est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Non-mandataire de Sa Majesté

Objects and purposes of Corporation

5. (1) The objects and purposes of the Corporation are to provide contributions to regional organizations with respect to projects described in subsection (2).
5. (1) La Société a pour mission de verser des contributions aux organisations régionales afin que celles-ci pourvoient au financement des travaux admissibles visés au paragraphe (2).
Mission

Eligible project

(2) The Corporation may only provide contributions to regional organizations in respect of a project if the project

(a) mitigates the existing or anticipated socio-economic impacts on communities in the Northwest Territories arising from the Mackenzie gas project; and

(b) is consistent with criteria established and made publicly available by the Corporation.
(2) La Société ne peut verser des contributions qu’à une organisation régionale et à l’égard de travaux qui, à la fois :
Travaux admissibles

a) atténuent les répercussions socio-économiques — ou le risque de telles répercussions — du projet gazier Mackenzie sur les collectivités des Territoires du Nord-Ouest;

b) sont conformes aux conditions établies et rendues publiques par la Société.

Capacity

6. In carrying out its objects and purposes, the Corporation has the capacity and, subject to this Act, the rights, powers and privileges of a natural person.
6. Pour l’exécution de sa mission, la Société a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité, les droits et les pouvoirs d’une personne physique.
Capacité, droits et pouvoirs d’une personne physique

Head office

7. The head office of the Corporation shall be in a place in Canada designated by the Governor in Council.
7. Le siège de la Société est fixé dans le lieu au Canada choisi par le gouverneur en conseil.
Siège

Canada Corporations Act

8. The Canada Corporations Act, chapter C-32 of the Revised Statutes of Canada, 1970, does not apply to the Corporation.
8. La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, ne s’applique pas à la Société.
Loi sur les corporations canadiennes

DIRECTORS
ADMINISTRATEURS
Board of directors

9. There shall be a board of directors consisting of either three or five persons, including the person appointed as chairperson.
9. Est constitué le conseil d’administration de la Société qui comprend trois ou cinq membres dont le président.
Conseil d’administration

Notice of appointment

10. (1) The Minister shall provide notice to the regional organizations at least one month before appointing the first director, other than the chairperson, under section 105 of the Financial Administration Act and each successor of that director.
10. (1) Le ministre avise les organisations régionales de son intention de nommer, aux termes de l’article 105 de la Loi sur la gestion des finances publiques, une première personne à titre d’administrateur de la Société, autrement qu’à titre de président, au moins un mois avant la date prévue pour la nomination. Le ministre les avise aussi de la même manière de son intention de nommer tout successeur de cette personne.
Avis

Nominees of regional organizations

(2) The regional organizations, on receiving the notice, may provide the Minister with a list of nominees for the appointment. The Minister shall consider the nominees before making the appointment.
(2) Les organisations régionales peuvent faire parvenir au ministre une liste de candidats que le ministre consulte avant de faire la nomination.
Liste

Eligibility for directors

(3) A person is not eligible to be appointed as a director if the person

(a) is a member of the Senate, the House of Commons or the legislature of a province;

(b) is an employee or agent of Her Majesty in right of Canada or in right of a province;

(c) does not ordinarily reside in Canada; or

(d) is disqualified under subsection 105(1) of the Canada Business Corporations Act.
(3) Ne peut occuper la fonction d’administrateur la personne :
Inadmissibilité

a) qui est membre du Sénat, de la Chambre des communes ou d’une législature provinciale;

b) qui est fonctionnaire ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;

c) qui ne réside pas habituellement au Canada;

d) qui est inadmissible aux termes du paragraphe 105(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

Limitation

(4) Until all directors are appointed, the Corporation shall not provide any contributions or enter into any agreements or arrangements, or review any applications, for or in respect of contributions.
(4) Il est interdit à la Société de verser une contribution, de conclure des accords, de prendre des arrangements ou d’examiner des demandes en vue de l’octroi d’une contribution tant que tous les administrateurs n’ont pas été nommés.
Restriction

Terms of office of directors

11. (1) The directors, other than the chairperson, shall be appointed to hold office during pleasure for terms not exceeding five years.
11. (1) Les administrateurs autres que le président sont nommés à titre amovible pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans.
Durée du mandat des administrateurs

Staggered terms

(2) The appointment of all directors shall ensure, as far as possible, the expiration in any one year of the terms of office of not more than one half of the directors of the Corporation.
(2) Les mandats des administrateurs, y compris celui du président, sont, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.
Échelonnement

Ceasing to be director

(3) A director ceases to be a director when the director

(a) dies;

(b) resigns;

(c) is appointed to the Senate;

(d) is elected to the House of Commons or to the legislature of a province;

(e) becomes an employee or agent of Her Majesty in right of Canada or in right of a province;

(f) ceases to be ordinarily resident in Canada; or

(g) becomes disqualified under subsection 105(1) of the Canada Business Corporations Act.
(3) L’administrateur cesse d’occuper son poste dans les situations suivantes :
Fin du mandat

a) il décède;

b) il démissionne;

c) il est nommé au Sénat;

d) il est élu à la Chambre des communes ou à la législature d’une province;

e) il devient fonctionnaire ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;

f) il cesse de résider habituellement au Canada;

g) il devient inadmissible aux termes du paragraphe 105(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

Director representation and experience

12. The appointment of directors shall be made having regard to the need for a board that has sufficient knowledge of, and experience in, financial administration and sufficient knowledge of the socio-economic issues affecting communities in northern regions.
12. Les administrateurs sont choisis de manière que, collectivement, le conseil dispose d’une expérience et une connaissance suffisante de la gestion financière et de connaissances suffisantes au sujet des questions socio-économiques relatives aux collectivités des régions nordiques.
Représentativité

Costs and expenses of Corporation

13. (1) The following shall be paid by the Corporation:

(a) the directors’ remuneration and benefits, in accordance with section 108 of the Financial Administration Act;

(b) the directors’ reasonable travel and living expenses incurred by them in the perform­ance of their duties under this Act while absent from their ordinary place of residence; and

(c) other costs and expenses of carrying on the business of the Corporation.
13. (1) La Société paie :
Rémunération et frais des administrateurs

a) la rémunération et les avantages des administrateurs prévus à l’article 108 de la Loi sur la gestion des finances publiques;

b) les frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice des fonctions des administrateurs hors de leur lieu de résidence habituelle;

c) les autres frais et dépenses découlant de ses activités.

Directors not to profit

(2) Except as provided under subsection (1), no director shall profit, gain any income or acquire any property, from the Corporation or its activities.
(2) Sous réserve du paragraphe (1), il est interdit aux administrateurs de tirer de la Société ou de ses activités, un profit, un revenu ou un bien.
Aucun profit pour les administrateurs

STAFF
PERSONNEL
Staff

14. (1) The board may appoint any officers, employees, agents and mandataries of the Corporation that it considers necessary to carry out the objects and purposes of the Corporation.
14. (1) Le conseil peut nommer les dirigeants, employés et mandataires qu’il estime nécessaires à la réalisation de la mission de la Société.
Personnel

Designation of offices

(2) Subject to the by-laws of the Corporation, the board may designate the offices of the Corporation and specify the duties and functions of each office.
(2) Sous réserve des règlements administratifs de la Société, le conseil peut créer les postes de direction de la Société et préciser les fonctions des titulaires.
Création de postes de direction

Directors not employees, agents or mandataries

(3) Directors are not eligible to be employees, agents or mandataries of the Corporation.
(3) Les administrateurs ne peuvent être employés ou mandataires de la Société.
Inadmissibilité

Not part of federal public administration

(4) The directors, officers, employees, agents and mandataries of the Corporation are not, because of being directors, officers, employees, agents and mandataries of the Corporation, part of the federal public administration.
(4) Les administrateurs, les dirigeants, les employés et les mandataires de la Société ne font pas, du fait de leurs fonctions, partie de l’administration publique fédérale.
Exclusion

OPERATIONS
OPÉRATIONS
Agreement with regional organizations

15. (1) The Corporation shall, before providing a contribution to a regional organization, enter into an agreement with the organization respecting, among other things,

(a) the manner in which advances will be made in respect of contributions and when those advances will be made;

(b) the terms or conditions on which the contributions will be provided; and

(c) the evaluation of the regional organization’s performance in achieving the objectives associated with the provision of contributions for eligible projects and the evaluation of the results of the projects that are funded.
15. (1) La Société, avant de verser une contribution à une organisation régionale, conclut avec celle-ci un accord portant notamment sur les points suivants :
Accord avec l’organisation régionale

a) les modalités — de temps et autres — de versement des avances sur la contribution;

b) les conditions de versement de la contribution;

c) l’appréciation du niveau de réalisation des objectifs par l’organisation régionale à l’égard du versement de la contribution pour les travaux admissibles, d’une part, et des résultats de ceux-ci, d’autres part.

Corporation not to acquire a benefit or interest

(2) In providing contributions to a regional organization, the Corporation shall not acquire any benefit or any interest, including an ownership interest, whether through the acquisition of share capital, a partnership interest or otherwise.
(2) Le versement de contributions à une organisation régionale ne permet pas à la Société d’en tirer quelque avantage que ce soit et ne lui confère aucun intérêt ou droit — de propriété ou autre —, que ce soit sous forme d’actions ou de participation dans une société de personnes ou autrement.
Restrictions

Investment policies

16. The board shall, with the approval of the Minister of Finance, establish investment policies, standards and procedures that a reasonably prudent person would apply in respect of a portfolio of investments to avoid undue risk of loss and obtain a reasonable return, having regard to the Corporation’s obligations and anticipated obligations.
16. Le conseil doit, avec l’approbation du ministre des Finances, établir, en matière de placement, des principes, normes et méthodes sur le modèle de ceux qu’une personne prudente mettrait en oeuvre dans la gestion d’un portefeuille de placements afin, d’une part, d’éviter des risques de perte indus et, d’autre part, d’assurer un juste rendement, compte tenu des obligations réelles et éventuelles de la Société.
Normes en matière de placement

Investments

17. (1) The Corporation shall invest its funds, and reinvest any income from those funds, in accordance with the investment policies, standards and procedures established by the board.
17. (1) La Société investit ses fonds, ainsi que le revenu en provenant, en conformité avec les principes, normes et méthodes établis par le conseil.
Placements

Incorporation of other corporations

(2) The Corporation shall not cause any corporation to be incorporated, participate in such an incorporation or become a partner in a partnership.
(2) Il est interdit à la Société de faire doter une entité de la personnalité morale, de participer à pareille dotation ou de devenir l’associée d’une société de personnes.
Constitution d’autres personnes morales

Control of Corporation

(3) Except for the investment of its funds, the Corporation shall not carry on any business for gain or profit and shall not hold or acquire any interest in any corporation or enterprise.
(3) Il est interdit à la Société d’exploiter une entreprise en vue d’un gain ou d’un bénéfice ou de détenir ou d’acquérir une participation dans une personne morale ou une entreprise, autrement que dans le cadre du placement de ses fonds.
Contrôle

Borrowing prohibited

18. (1) Except as permitted under its corporate plan approved in accordance with section 122 of the Financial Administration Act, the Corporation shall not borrow money, issue any debt obligations or securities, give any guarantees to secure a debt or other obligation of another person or mortgage, hypothecate, pledge or otherwise encumber property of the Corporation.
18. (1) À moins que cela ne soit prévu dans le plan d’entreprise approuvé conformément à l’article 122 de la Loi sur la gestion des finances publiques, il est interdit à la Société de contracter des emprunts, d’émettre des titres de créance ou des valeurs mobilières, de garantir les dettes ou autres obligations d’un tiers ou d’hypothéquer les biens de la Société, de les donner en garantie ou de les grever autrement.
Interdiction d’emprunt

Real property or immovables

(2) The Corporation shall not purchase or accept a donation of real property or immovables.
(2) Il est interdit à la Société d’acquérir, à titre onéreux ou à titre gratuit, des immeubles ou des biens réels.
Immeubles ou biens réels

Delegation by board

19. (1) Subject to subsection (2), the board may delegate to the chairperson, a committee of directors or an officer of the Corporation any of the powers or rights of the board.
19. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs ou de ses droits au président, à un comité d’administrateurs ou à un dirigeant de la Société.
Délégation par le conseil

Restrictions on delegation

(2) The board shall not delegate any power or right of the board

(a) to enact, amend or repeal by-laws;

(b) to authorize the provision of contributions to regional organizations for eligible projects;

(c) to appoint officers of the Corporation or fix their remuneration; or

(d) to approve the annual financial statements or reports of the Corporation.
(2) Il est interdit au conseil de déléguer le pouvoir ou droit :
Restrictions

a) d’adopter, de modifier ou d’abroger des règlements administratifs;

b) d’autoriser le versement de contributions;

c) de nommer les dirigeants de la Société ou de fixer leur rémunération;

d) d’approuver les états financiers annuels ou les rapports de la Société.

LIQUIDATION
LIQUIDATION
Order

20. The Governor in Council may, by order, require the Corporation to cease carrying on business and liquidate its assets.
20. Le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner que la Société cesse ses activités et que ses biens soient liquidés.
Décret

Distribution

21. Any money remaining after liquidation shall be distributed in accordance with instructions given by the Governor in Council.
21. Le produit net de la liquidation de la Société est réparti conformément aux instructions du gouverneur en conseil.
Répartition

GENERAL
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Mandatory by-laws

22. The Corporation shall include in its by-laws provisions

(a) entitling a regional organization that has made an application for a contribution from the Corporation to request the board to make a ruling as to the possible conflict of interest of a director in the consideration or disposal of the application;

(b) establishing procedures to be followed by the board in responding to the request and giving the ruling; and

(c) determining the fiscal year of the Corporation.
22. Les règlements administratifs de la Société doivent comporter des dispositions :
Règlements administratifs obligatoires

a) permettant à l’organisation régionale ayant présenté une demande de contribution à la Société de demander au conseil de trancher quant à toute situation de conflit d’intérêts dans laquelle pourrait se trouver un administrateur pour l’examen de la demande ou la décision à prendre à cet égard;

b) prévoyant la marche à suivre par le conseil pour répondre à la demande et rendre sa décision;

c) fixant l’exercice de la Société.

Inconsistencies

23. In the event of an inconsistency between the provisions of this Act and the provisions of Part X of the Financial Administration Act, the provisions of this Act prevail.
23. Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Incompatibilité

AMENDMENT OF SCHEDULE
MODIFICATION DE L’ANNEXE
Order in Council

24. The Governor in Council may, by order made on the recommendation of the Minister, add or delete the name of any organization to or from the schedule.
24. Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du ministre, ajouter à l’annexe ou en retrancher le nom de toute organisation.
Décret

Payments
Prélèvement
Payment of $500,000,000

209. (1) From and out of the Consolidated Revenue Fund, there may, on the requisition of the Minister of Finance made on the recommendation of the Minister of Indian Affairs and Northern Development, be paid to the Corporation for the Mitigation of Mackenzie Gas Project Impacts payments not exceeding in the aggregate the sum of $500,000,000.
209. (1) À la demande du ministre des Finances faite sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, peuvent être prélevées sur le Trésor et versées à la Société d’atténuation des répercussions du projet gazier Mackenzie des sommes n’excédant pas la somme totale de 500 000 000 $.
Paiement de 500 000 000 $

Condition for recommendation

(2) The Minister of Indian Affairs and Northern Development may only make the recommendation if the Mackenzie gas project, as defined in section 2 of the Mackenzie Gas Project Impacts Act, as enacted by section 208 of this Act, has not been terminated and the Minister of Indian Affairs and Northern Development is of the opinion that progress is being made on the project.
(2) Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien ne peut faire la recommandation visée au paragraphe (1) que s’il n’a pas été mis fin au projet gazier Mackenzie, au sens de l’article 2 de la Loi relative aux répercussions du projet gazier Mackenzie, édictée par l’article 208 de la présente loi, et qu’il est d’avis que des progrès sont réalisés dans sa mise en oeuvre.
Recommandation

Terms and conditions

(3) The Minister of Indian Affairs and Northern Development may, with the concurrence of the Minister of Finance, enter into an agreement with the Corporation for the Mitigation of Mackenzie Gas Project Impacts respecting the terms and conditions applicable to the making of the payments and their use.
(3) Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien peut, avec l’agrément du ministre des Finances, conclure un accord avec la Société d’atténuation des répercussions du projet gazier Mackenzie concernant les conditions de versement et d’utilisation des sommes.
Conditions

Consequential Amendments
Modifications corrélatives
R.S., c. A-1

Access to Information Act
Loi sur l’accès à l’information
L.R., ch. A-1

210. Schedule I to the Access to Information Act is amended by adding the following in alphabetical order under the heading “Other Government Institutions”:
210. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Corporation for the Mitigation of Mackenzie Gas Project Impacts
Société d’atténuation des répercussions du projet gazier Mackenzie
Société d’atténuation des répercussions du projet gazier Mackenzie
Corporation for the Mitigation of Mackenzie Gas Project Impacts
R.S., c. F-11

Financial Administration Act
Loi sur la gestion des finances publiques
L.R., ch. F-11

211. Part 1 of Schedule III to the Financial Administration Act is amended adding the following in alphabetical order:
211. La partie I de l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Corporation for the Mitigation of Mackenzie Gas Project Impacts
Société d’atténuation des répercussions du projet gazier Mackenzie
Société d’atténuation des répercussions du projet gazier Mackenzie
Corporation for the Mitigation of Mackenzie Gas Project Impacts
R.S., c. P-21

Privacy Act
Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R., ch. P-21

212. The schedule to the Privacy Act is amended by adding the following in alphabetical order under the heading “Other Government Institutions”:
212. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Corporation for the Mitigation of Mackenzie Gas Project Impacts
Société d’atténuation des répercussions du projet gazier Mackenzie
Société d’atténuation des répercussions du projet gazier Mackenzie
Corporation for the Mitigation of Mackenzie Gas Project Impacts
Coming Into Force
Entrée en vigueur
Order in Council

213. Sections 208 to 212 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
213. Les articles 208 à 212 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Décret

PART 13
PARTIE 13
MISCELLANEOUS AMENDMENTS
MODIFICATIONS DIVERSES
1991, c. 12

European Bank for Reconstruction and Development Agreement Act
Loi sur l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement
1991, ch. 12

214. The European Bank for Reconstruction and Development Agreement Act is amended by adding the following after section 4:
214. La Loi sur l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
Amendment to schedule

4.1 The Governor in Council may, by order, amend the schedule to reflect amendments to the Agreement.
4.1 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour tenir compte des amendements à l’Accord.
Modification de l’annexe

215. Article 1 of the Agreement set out in the schedule to the Act is replaced by the following:
215. L’article 1 de l’Accord figurant à l’annexe de la même loi est remplacé par ce qui suit :
ARTICLE 1
ARTICLE 1
Purpose
Objet
In contributing to economic progress and reconstruction, the purpose of the Bank shall be to foster the transition towards open market-oriented economies and to promote private and entrepreneurial initiative in the Central and Eastern European countries committed to and applying the principles of multiparty democracy, pluralism and market economics. The purpose of the Bank may also be carried out in Mongolia subject to the same conditions. Accordingly, any reference in this Agreement and its annexes to “Central and Eastern European countries”, “countries from Central and Eastern Europe”, “recipient country (or countries)” or “recipient member country (or countries)” shall refer to Mongolia as well.
L’objet de la Banque est, en contribuant au progrès et à la reconstruction économiques des pays d’Europe centrale et orientale qui s’engagent à respecter et mettent en pratique les principes de la démocratie pluraliste, du pluralisme et de l’économie de marché, de favoriser la transition de leurs économies vers des économies de marché, et d’y promouvoir l’initiative privée et l’esprit d’entreprise. L’objet de la Banque peut également être mis en oeuvre en Mongolie sous les mêmes conditions. En conséquence, toute référence dans le présent Accord et dans ses annexes aux « pays d’Europe centrale et orientale », à un ou plusieurs « pays bénéficiaires » ou aux « pays membres bénéficiaires » s’applique également à la Mongolie.
R.S., c. F-13

Freshwater Fish Marketing Act
Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce
L.R., ch. F-13

216. Subsection 16(2) of the Freshwater Fish Marketing Act is replaced by the following:
216. Le paragraphe 16(2) de la Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce est remplacé par ce qui suit :
Limitation

(2) The aggregate outstanding at any time of the amounts borrowed by the Corporation pursuant to paragraph 7(g) and the amounts lent by the Minister of Finance under this section shall not exceed fifty million dollars.
(2) Le total non remboursé des montants ayant été, d’une part, empruntés par l’Office au titre de l’alinéa 7g) et, d’autre part, prêtés par le ministre des Finances en vertu du présent article ne peut, à aucun moment, dépasser cinquante millions de dollars.
Plafonnement

1999, c. 34

Public Sector Pension Investment Board Act
Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public
1999, ch. 34

217. The Public Sector Pension Investment Board Act is amended by adding the following after section 3:
217. La Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
CAPITAL AND SHARES
CAPITAL-ACTIONS
Capital

3.1 (1) The capital of the Board is $100. The Minister shall pay the capital of the Board out of the Consolidated Revenue Fund.
3.1 (1) Le capital de l’Office est de cent dollars. Ce montant est prélevé sur le Trésor par le ministre.
Capital

Shares

(2) The capital is divided into 10 shares having a par value of $10 each. The shares shall be issued to the Minister to be held on behalf of Her Majesty in right of Canada.
(2) Le capital est réparti en dix actions d’une valeur nominale de dix dollars chacune, émises et attribuées au ministre pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada.
Actions

Registration

(3) The shares issued to the Minister shall be registered by the Board in the name of the Minister.
(3) Les actions émises sont enregistrées par l’Office au nom du ministre.
Enregistrement