Skip to main content

Bill C-38

If you have any questions or comments regarding the accessibility of this publication, please contact us at accessible@parl.gc.ca.

INCORPORATION BY REFERENCE
INCORPORATION PAR RENVOI
Externally produced material

89. (1) A regulation made under this Act may incorporate by reference material produced by a person or body other than the Minister, including by a government, a government agency or an international body.
89. (1) Peut être incorporé par renvoi dans tout règlement pris en vertu de la présente loi tout document produit par une personne ou un organisme autre que le ministre, notamment par un gouvernement, un organisme public ou une organisation internationale.
Documents externes

Jointly produced material

(2) A regulation made under this Act may incorporate by reference material produced jointly by the Minister and a government or government agency for the purpose of harmonizing the regulation with other laws.
(2) Peut être incorporé par renvoi dans tout règlement pris en vertu de la présente loi tout document produit conjointement par le ministre et un organisme de droit public en vue d’harmoniser le règlement avec d’autres règles de droit.
Documents produits conjointement

Internally produced standards

(3) A regulation made under this Act may incorporate by reference technical or explanatory material produced by the Minister, such as specifications, test methods, procedures, construction standards, operational standards, safety standards and performance standards of a technical nature.
(3) Peut être incorporé par renvoi dans tout règlement pris en vertu de la présente loi tout document de nature technique ou explicative produit par le ministre, notamment des spécifications, des méthodes d’essai, des procédures ou des normes de construction, d’exploitation, de rendement ou de sécurité.
Documents internes

Incorporation as amended from time to time

(4) Material may be incorporated by reference as it exists on a particular date or as it is amended from time to time.
(4) L’incorporation par renvoi peut viser le document soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Portée de l’incorporation par renvoi

Transmission and publication

(5) For greater certainty, a document that is incorporated by reference in a regulation is not required to be transmitted for registration or publication in the Canada Gazette by reason only that it is incorporated by reference.
(5) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans un règlement n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.
Transmission et publication

Interpretation

(6) Subsections (1) to (5) do not limit any authority to make regulations incorporating material by reference that exists apart from those subsections.
(6) Les paragraphes (1) à (5) n’ont pas pour objet d’empêcher la prise de règlements incorporant par renvoi des documents autres que ceux qui y sont visés.
Interprétation

Defence

90. A person is not liable to be found guilty of an offence for any contravention in respect of which a document that is incorporated by reference in a regulation is relevant unless, at the time of the alleged contravention, it was accessible as required by section 91 or was accessible to the person.
90. Aucune déclaration de culpabilité ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document, indice, taux ou nombre — incorporé par renvoi dans un règlement — se rapportant au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document, indice, taux ou nombre était accessible en application de l’article 91 ou était accessible à la personne en cause.
Moyen de défense

Accessibility of incorporated documents

91. The Minister shall ensure that any document that is incorporated by reference under subsection 89(1) is accessible.
91. Le ministre veille à ce que tout document incorporé par renvoi en vertu du paragraphe 89(1) soit accessible.
Accessibilité

Coming into Force
Entrée en vigueur
Order in council

156. Section 132, subsections 133(1), (3) and (4), sections 135 to 138, subsection 139(2), sections 140 and 141, subsections 142(2) to (4), 144(2) to (6), 145(2) to (4) and 147(1) to (5), (7), (9) and (10), section 148, subsections 149(2) and (5) and sections 152 and 153 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
156. L’article 132, les paragraphes 133(1), (3) et (4), les articles 135 à 138, le paragraphe 139(2), les articles 140 et 141, les paragraphes 142(2) à (4), 144(2) à (6), 145(2) à (4) et 147(1) à (5), (7), (9) et (10), l’article 148, les paragraphes 149(2) et (5) et les articles 152 et 153 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Décret

Division 6
Section 6
1999, c. 33

Canadian Environmental Protection Act, 1999
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
1999, ch. 33

Amendments to the Act
Modification de la loi
157. (1) Subsection 127(1) of the Canadian Environmental Protection Act, 1999 is replaced by the following:
157. (1) Le paragraphe 127(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est remplacé par ce qui suit :
Permit

127. (1) The Minister may, on application, issue a permit authorizing the loading for disposal and disposal of waste or other matter and, subject to the regulations, renew it no more than four times.
127. (1) Le ministre peut, sur demande, délivrer un permis pour le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou autres matières et, sous réserve des règlements, le renouveler jusqu’à quatre fois.
Permis

(2) The portion of subsection 127(2) of the English version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 127(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Application

(2) The application must
(2) The application must
Application

(3) Subsection 127(3) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 127(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Factors for consideration

(3) Before issuing a permit under subsection (1) or renewing it, the Minister shall comply with Schedule 6 and shall take into account any factors that the Minister considers necessary.
(3) Le ministre ne peut délivrer ou renouveler le permis que s’il se conforme à l’annexe 6 et considère tout facteur qu’il juge utile.
Facteurs à considérer

158. Subsection 129(2) of the Act is replaced by the following:
158. Le paragraphe 129(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Duration of permit

(2) A Canadian permit shall specify that it is valid for a particular date or dates or for a particular period that shall not exceed one year. For greater certainty, this subsection applies to each renewal of a permit issued under subsection 127(1).
(2) Le permis canadien indique la ou les dates pendant lesquelles il est valide ou encore, sa durée de validité, laquelle ne peut dépasser un an. Il est entendu que le présent paragraphe s’applique à chaque renouvellement de permis délivré en vertu du paragraphe 127(1).
Durée de validité du permis

159. (1) Subsection 133(1) of the Act is replaced by the following:
159. (1) Le paragraphe 133(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Publication

133. (1) When issuing a Canadian permit or varying any of its conditions, the Minister shall publish the text of the permit or the varied condition, as the case may be, in the Environmental Registry.
133. (1) Lorsqu’il délivre tout permis canadien ou en modifie les conditions, le ministre publie dans le Registre le texte du permis ou des conditions modifiées, selon le cas.
Publication

(2) Subsection 133(1) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 133(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Publication

133. (1) When issuing a Canadian permit or varying any of its conditions or renewing a permit issued under subsection 127(1), the Minister shall publish the text of the permit, the varied condition or the renewed permit, as the case may be, in the Environmental Registry.
133. (1) Lorsqu’il délivre tout permis canadien, en modifie les conditions ou renouvelle le permis délivré en vertu du paragraphe 127(1), le ministre publie dans le Registre le texte du permis délivré ou renouvelé ou des conditions modifiées, selon le cas.
Publication

(3) Paragraph 133(2)(b) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 133(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) in every other case, at least seven days before the effective date of the permit or of the variation of its conditions.
b) dans les autres cas, au moins sept jours avant la date de prise d’effet du permis ou de la modification de ses conditions.
(4) Paragraph 133(2)(b) of the Act is replaced by the following:
(4) L’alinéa 133(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) in every other case, at least seven days before the effective date of the permit, the variation of its conditions or its renewal.
b) dans les autres cas, au moins sept jours avant la date de prise d’effet du permis, de son renouvellement ou de la modification de ses conditions.
160. (1) Subsection 134(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (a) and by adding the following after that paragraph:
160. (1) Le paragraphe 134(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
(a.1) renews or refuses to renew a permit issued under subsection 127(1); or
a.1) le ministre renouvelle ou refuse de renouveler le permis délivré en vertu du paragraphe 127(1);
(2) The portion of subsection 134(2) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 134(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Time for filing notice of objection

(2) The notice of objection shall be filed within seven days after

(a) the date the text of the Canadian permit is published in the Environmental Registry; or
(2) L’avis d’opposition doit être déposé dans les sept jours suivant :
Délai de dépôt

a) la publication du texte du permis canadien dans le Registre;

(3) Paragraph 134(2)(a) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 134(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) the date the text of the Canadian permit or the permit renewed under subsection 127(1), as the case may be, is published in the Environmental Registry; or
a) la publication dans le Registre du texte du permis canadien ou du permis renouvelé en vertu du paragraphe 127(1);
(4) Paragraph 134(2)(b) of the English version of the Act is replaced by the following:
(4) L’alinéa 134(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the date the person receives a notice from the Minister that the Canadian permit has been refused, suspended or revoked, that its conditions have been varied or that the renewal of a permit issued under subsection 127(1) has been refused.
(b) the date the person receives a notice from the Minister that the Canadian permit has been refused, suspended or revoked, that its conditions have been varied or that the renewal of a permit issued under subsection 127(1) has been refused.
161. (1) Subsection 135(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (b):
161. (1) Le paragraphe 135(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(b.1) respecting time limits for issuing permits under subsection 127(1) or for refusing to issue them, specifying the circumstances under which any of those time limits do not apply and authorizing the Minister to extend any of those time limits or to decide that a time limit does not apply when the Minister considers that it is appropriate to do so;
b.1) régir les délais à respecter pour délivrer un permis en vertu du paragraphe 127(1) ou refuser de le faire, prévoir les circonstances où l’un ou l’autre de ces délais ne s’applique pas et autoriser le ministre, dans les cas où il l’estime indiqué, à proroger l’un ou l’autre de ces délais ou à décider qu’il ne s’applique pas;
(2) Subsection 135(1) of the Act is amended by adding the following before paragraph (c):
(2) Le paragraphe 135(1) de la même loi est modifié par adjonction, avant l’alinéa c), de ce qui suit :
(b.2) respecting the renewal of permits under subsection 127(1), including regulations respecting time limits for renewing them or for refusing to renew them, specifying the circumstances under which any of those time limits do not apply and authorizing the Minister to extend any of those time limits or to decide that a time limit does not apply when the Minister considers that it is appropriate to do so;
b.2) régir le renouvellement des permis en vertu du paragraphe 127(1), notamment régir les délais à respecter pour renouveler de tels permis ou refuser de le faire, prévoir les circonstances où l’un ou l’autre de ces délais ne s’applique pas et autoriser le ministre, dans les cas où il l’estime indiqué, à proroger l’un ou l’autre de ces délais ou à décider qu’il ne s’applique pas;
2005, c. 23 s. 26

(3) Paragraph 135(3)(a) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 135(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 23, art. 26

(a) prescribing the form of an application for a Canadian permit or for the renewal of a permit issued under subsection 127(1);
a) fixer la forme des demandes de permis canadien et des demandes de renouvellement des permis délivrés en vertu du paragraphe 127(1);
2005, c. 23 s. 26

(4) Paragraph 135(3)(b) of the English version of the Act is replaced by the following:
(4) L’alinéa 135(3)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 23, art. 26

(b) specifying the information required to be contained in or to accompany an application referred to in paragraph (a);
(b) specifying the information required to be contained in or to accompany an application referred to in paragraph (a);
Coming into Force
Entrée en vigueur
Order in council

162. Sections 157 and 158 and subsections 159(2) and (4), 160(1), (3) and (4) and 161(2) and (3) come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
162. Les articles 157 et 158 et les paragraphes 159(2) et (4), 160(1), (3) et (4) et 161(2) et (3) entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret

Division 7
Section 7
2002, c. 29

Species at Risk Act
Loi sur les espèces en péril
2002, ch. 29

163. (1) Section 73 of the Species at Risk Act is amended by adding the following after subsection (6):
163. (1) L’article 73 de la Loi sur les espèces en péril est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Date of expiry

(6.1) The agreement or permit must set out the date of its expiry.
(6.1) La date d’expiration de l’accord ou du permis doit y figurer.
Date d’expiration

(2) Subsection 73(9) of the Act is repealed.
(2) Le paragraphe 73(9) de la même loi est abrogé.
(3) Section 73 of the Act is amended by adding the following after subsection (10):
(3) L’article 73 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :
Time limits

(11) The regulations may include provisions

(a) respecting time limits for issuing or renewing permits, or for refusing to do so;

(b) specifying the circumstances under which any of those time limits does not apply; and

(c) authorizing the competent minister to extend any of those time limits or to decide that a time limit does not apply, when the competent minister considers that it is appropriate to do so.
(11) Les règlements peuvent notamment :
Délais

a) régir les délais à respecter pour délivrer ou renouveler le permis ou refuser de le faire;

b) prévoir les circonstances où l’un ou l’autre de ces délais ne s’applique pas;

c) autoriser le ministre compétent, dans les cas où il l’estime indiqué, à proroger l’un ou l’autre de ces délais ou à décider qu’il ne s’applique pas.

164. Paragraph 74(a) of the Act is replaced by the following:
164. L’alinéa 74a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) before it is entered into, issued or made, the competent minister is of the opinion that the requirements of subsections 73(2) to (6.1) are met; and
a) avant la conclusion, la délivrance ou la prise, le ministre compétent estime que les exigences des paragraphes 73(2) à (6.1) sont remplies;
165. Section 77 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
165. L’article 77 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Non-application

(1.1) Subsection (1) does not apply to the National Energy Board when it issues a certificate under an order made under subsection 54(1) of the National Energy Board Act.
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’Office national de l’énergie lorsqu’il délivre un certificat conformément à un décret pris en vertu du paragraphe 54(1) de la Loi sur l’Office national de l’énergie.
Non-application

166. Paragraph 78(1)(a) of the Act is replaced by the following:
166. L’alinéa 78(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) before it is entered into, issued or made, the provincial or territorial minister determines that the requirements of subsections 73(2), (3), (6) and (6.1) are met;
a) avant la conclusion, la délivrance ou la prise, le ministre provincial ou territorial s’assure que les exigences des paragraphes 73(2), (3), (6) et (6.1) sont remplies;
167. The Act is amended by adding the following after section 78:
167. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 78, de ce qui suit :
Clarification — renewals

78.1 For greater certainty, a reference in any of sections 73 to 78 to the entering into, issuing, making or approving of any agreement, permit, licence, order or other similar document or authorization, includes renewing it, and a reference in any of those sections or in paragraph 97(1)(c) to any such document or authorization includes one that has been renewed.
78.1 Il est entendu que la mention, aux articles 73 à 78, de la conclusion, de la délivrance, de la prise ou de l’agrément d’un accord, d’un permis, d’une licence ou d’un arrêté — ou de tout autre document ou autorisation semblable — vise notamment leur renouvellement et la mention, à ces articles et à l’alinéa 97(1)c), de l’un ou l’autre de ces documents ou autorisations vise notamment le document ou l’autorisation renouvelés.
Clarification — renouvellement

168. (1) Subsection 97(1) of the Act is replaced by the following:
168. (1) Le paragraphe 97(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Offences

97. (1) Every person commits an offence who

(a) contravenes subsection 32(1) or (2), section 33, subsection 36(1), 58(1), 60(1) or 61(1) or section 91 or 92;

(b) contravenes a prescribed provision of a regulation or an emergency order;

(c) fails to comply with a term or condition of a permit issued under subsection 73(1); or

(d) fails to comply with an alternative measures agreement that the person has entered into under this Act.
97. (1) Commet une infraction quiconque contrevient :
Infractions

a) aux paragraphes 32(1) ou (2), à l’article 33, aux paragraphes 36(1), 58(1), 60(1) ou 61(1) ou aux articles 91 ou 92;

b) à toute disposition d’un règlement ou d’un décret d’urgence précisée par ce règlement ou ce décret;

c) à toute condition d’un permis délivré en vertu du paragraphe 73(1);

d) à un accord sur des mesures de rechange conclu sous le régime de la présente loi.

Penalty

(1.1) Every person who commits an offence under subsection (1) is liable

(a) on conviction on indictment,

(i) in the case of a corporation, other than a non-profit corporation, to a fine of not more than $1,000,000,

(ii) in the case of a non-profit corporation, to a fine of not more than $250,000, and

(iii) in the case of any other person, to a fine of not more than $250,000 or to imprisonment for a term of not more than five years, or to both; or

(b) on summary conviction,

(i) in the case of a corporation, other than a non-profit corporation, to a fine of not more than $300,000,

(ii) in the case of a non-profit corporation, to a fine of not more than $50,000, and

(iii) in the case of any other person, to a fine of not more than $50,000 or to imprisonment for a term of not more than one year, or to both.
(1.1) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
Peine

a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

(i) dans le cas d’une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif, d’une amende maximale de 1 000 000 $,

(ii) dans le cas d’une personne morale sans but lucratif, d’une amende maximale de 250 000 $,

(iii) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;

b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

(i) dans le cas d’une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif, d’une amende maximale de 300 000 $,

(ii) dans le cas d’une personne morale sans but lucratif, d’une amende maximale de 50 000 $,

(iii) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.

Exception

(1.2) Paragraph (1)(c) does not apply in respect of the failure to comply with any term or condition of any agreement, permit, licence, order or other similar document referred to in section 74 or subsection 78(1).
(1.2) L’alinéa (1)c) ne s’applique pas à l’égard de la contravention à toute condition d’un accord, d’un permis, d’une licence ou d’un arrêté — ou d’un autre document semblable — qui est visé à l’article 74 ou au paragraphe 78(1).
Exception

(2) Subsection 97(3) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 97(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Subsequent offence

(3) For a second or subsequent conviction, the amount of the fine may, despite subsection (1.1), be double the amount set out in that subsection.
(3) Le montant des amendes prévues au paragraphe (1.1) peut être doublé en cas de récidive.
Récidive

(3) Subsection 97(7) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 97(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Definition of “non-profit corporation”

(7) For the purposes of subsection (1.1), “non-profit corporation” means a corporation, no part of the income of which is payable to, or is otherwise available for, the personal benefit of any proprietor, member or shareholder of the corporation.
(7) Pour l’application du paragraphe (1.1), « personne morale sans but lucratif » s’entend d’une personne morale dont aucune partie du revenu n’est payable à un propriétaire, membre ou actionnaire de celle-ci, ou ne peut par ailleurs servir au profit personnel de ceux-ci.
Définition de « personne morale sans but lucratif »

169. Paragraph 126(d) of the Act is replaced by the following:
169. L’alinéa 126d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) all agreements entered into or renewed under section 73, all permits issued or renewed under that section and all agreements and permits amended under section 75 or exempted under section 76;
d) les accords conclus ou renouvelés et les permis délivrés ou renouvelés en vertu de l’article 73, les accords et les permis modifiés en vertu de l’article 75, et les exonérations prévues à l’article 76;
PART 4
PARTIE 4
VARIOUS MEASURES
DIVERSES MESURES
Division 1
Section 1
Measures with Respect to the Auditor General of Canada
Mesures relatives au vérificateur général du Canada
R.S., c. C-13

Canadian Centre for Occupational Health and Safety Act
Loi sur le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail
L.R., ch. C-13

170. Section 25 of the Canadian Centre for Occupational Health and Safety Act and the heading before it are repealed.
170. L’article 25 de la Loi sur le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail et l’intertitre le précédant sont abrogés.
171. Subsection 26(1) of the Act is replaced by the following:
171. Le paragraphe 26(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Annual report

26. (1) Within four months after the end of each year, the Council shall submit to the Minister a report on the activities of the Centre for that year, including a summary of the disposition of briefs and other written representations considered by the Centre as required by subsection 6(2) and the financial statements of the Centre.
26. (1) Dans les quatre premiers mois de chaque année, le conseil présente au ministre un rapport sur l’activité du Centre au cours de l’année précédente, en y incluant un résumé de la suite donnée aux mémoires et autres observations écrites étudiés par le Centre en application du paragraphe 6(2) ainsi que les états financiers de celui-ci.
Rapport annuel

R.S., c. C-52

Currency Act
Loi sur la monnaie
L.R., ch. C-52

2005, c. 30, s. 114

172. Subsection 21(2) of the Currency Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (d), by striking out “and” at the end of paragraph (e) and by repealing paragraph (f).
172. L’alinéa 21(2)f) de la Loi sur la monnaie est abrogé.
2005, ch. 30, art. 114

2005, c. 30, s. 115

173. Subsection 22(2) of the Act is repealed.
173. Le paragraphe 22(2) de la même loi est abrogé.
2005, ch. 30, art. 115

R.S., c. N-21

Natural Sciences and Engineering Research Council Act
Loi sur le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie
L.R., ch. N-21

174. Section 17 of the Natural Sciences and Engineering Research Council Act and the heading before it are repealed.
174. L’article 17 de la Loi sur le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie et l’intertitre le précédant sont abrogés.
175. Subsection 18(1) of the Act is replaced by the following:
175. Le paragraphe 18(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Annual report

18. (1) The President shall, within four months after the end of each fiscal year, submit to the Minister a report on the activities of the Council for that fiscal year, including the financial statements of the Council.
18. (1) Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, le président présente au ministre un rapport sur l’activité du Conseil au cours de l’exercice ainsi que les états financiers de celui-ci.
Rapport annuel

R.S., c. N-26

Northern Pipeline Act
Loi sur le pipe-line du Nord
L.R., ch. N-26

176. The heading before section 13 of the Northern Pipeline Act is replaced by the following:
176. L’intertitre précédant l’article 13 de la Loi sur le pipe-line du Nord est remplacé par ce qui suit :
Annual Report
Rapport annuel
177. Sections 13 and 14 of the Act are replaced by the following:
177. Les articles 13 et 14 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Annual report

14. The Minister shall, on or before December 31 next following the end of each fiscal year, prepare a report on the operations of the Agency for that fiscal year and the Minister shall cause the report to be laid before each House of Parliament on that date or, if a House is not then sitting, on any of the first 15 days that it is sitting after that date.
14. Au plus tard le 31 décembre suivant la fin de chaque exercice, le ministre établit un rapport sur les opérations de l’Administration au cours de cet exercice et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement à cette date ou, si celle-ci ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.
Rapport annuel

R.S., c. S-12

Social Sciences and Humanities Research Council Act
Loi sur le Conseil de recherches en sciences humaines
L.R., ch. S-12

178. Section 19 of the Social Sciences and Humanities Research Council Act and the heading before it are repealed.
178. L’article 19 de la Loi sur le Conseil de recherches en sciences humaines et l’intertitre le précédant sont abrogés.
179. Subsection 20(1) of the Act is replaced by the following:
179. Le paragraphe 20(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Annual report

20. (1) The President shall, within four months after the end of each fiscal year, submit to the Minister a report on the activities of the Council for that fiscal year, including the financial statements of the Council.
20. (1) Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, le président présente au ministre un rapport sur l’activité du Conseil au cours de l’exercice ainsi que les états financiers de celui-ci.
Rapport annuel

1989, c. 3

Canadian Transportation Accident Investigation and Safety Board Act
Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports
1989, ch. 3

180. Subsection 13(2) of the Canadian Transportation Accident Investigation and Safety Board Act is repealed.
180. Le paragraphe 13(2) de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports est abrogé.
1991, c. 6

Canadian Polar Commission Act
Loi sur la Commission canadienne des affaires polaires
1991, ch. 6

181. Section 20 of the Canadian Polar Commission Act and the heading before it are repealed.
181. L’article 20 de la Loi sur la Commission canadienne des affaires polaires et l’intertitre le précédant sont abrogés.
182. Subsection 21(1) of the Act is replaced by the following:
182. Le paragraphe 21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Annual report

21. (1) Within the first four months after the commencement of each fiscal year, the Chairperson shall submit to the Minister a report on the activities of the Commission for the preceding fiscal year, including the financial statements of the Commission, and the Commission shall make the annual report available for public scrutiny at the offices of the Commission.
21. (1) Dans les quatre premiers mois de chaque exercice de la Commission, le président présente au ministre le rapport d’activité de celle-ci pour l’exercice précédent, y compris les états financiers afférents. La Commission tient le rapport d’activité à la disposition du public à ses bureaux.
Rapport annuel

1993, c. 31

National Round Table on the Environment and the Economy Act
Loi sur la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie
1993, ch. 31

183. Section 22 of the National Round Table on the Environment and the Economy Act is repealed.
183. L’article 22 de la Loi sur la Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie est abrogé.
184. Subsection 23(1) of the Act is replaced by the following:
184. Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Annual report

23. (1) Within four months after the end of each fiscal year, the Chairperson shall submit to the Minister a report on the activities of the Round Table during that fiscal year, including the financial statements of the Round Table.
23. (1) Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, le président présente au ministre le rapport d’activité de l’Organisme pour l’exercice ainsi que les états financiers de celui-ci.
Rapport annuel

1994, c. 43

Yukon Surface Rights Board Act
Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon
1994, ch. 43

185. Subsection 23(5) of the Yukon Surface Rights Board Act is repealed.
185. Le paragraphe 23(5) de la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon est abrogé.
1997, c. 6

Canadian Food Inspection Agency Act
Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments
1997, ch. 6

186. Paragraphs 23(2)(a) and (b) of the Canadian Food Inspection Agency Act are replaced by the following:
186. Les alinéas 23(2)a) et b) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments sont remplacés par ce qui suit :
(a) the financial statements of the Agency;
(b) information about the Agency’s perform-ance with respect to the objectives established in the corporate business plan; and
a) les états financiers de l’Agence;
b) des renseignements sur les résultats obtenus par rapport aux objectifs mentionnés dans le plan d’entreprise;
187. The heading before section 31 of the Act is replaced by the following:
187. L’intertitre précédant l’article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
ACCOUNTING
DOCUMENTS COMPTABLES
188. Section 32 of the Act is repealed.
188. L’article 32 de la même loi est abrogé.
1999, c. 17; 2005, c. 38, s. 35

Canada Revenue Agency Act
Loi sur l’Agence du revenu du Canada
1999, ch. 17; 2005, ch. 38, art. 35

189. Section 87 of the Canada Revenue Agency Act is replaced by the following:
189. L’article 87 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada est remplacé par ce qui suit :
Audits

87. The Auditor General of Canada is the auditor for the Agency and must

(a) annually audit and provide an opinion to the Agency and the Minister on the financial statements of the Agency; and

(b) provide the Minister, the Commissioner and the Board with copies of reports of audits carried out under this section.
87. Le vérificateur général du Canada est le vérificateur de l’Agence. À ce titre, il s’acquitte des tâches suivantes :
Vérification

a) il examine chaque année les états financiers de l’Agence et donne à celle-ci et au ministre son avis sur ceux-ci;

b) il présente au ministre, au commissaire et au conseil une copie du rapport portant sur son examen fait en application du présent article.

190. Paragraph 88(2)(b) of the Act is replaced by the following:
190. L’alinéa 88(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) information about the Agency’s perform-ance with respect to the objectives established in the corporate business plan;
b) des renseignements sur les résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés dans le plan d’entreprise;
2000, c. 6

Canadian Institutes of Health Research Act
Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada
2000, ch. 6

191. Section 31 of the Canadian Institutes of Health Research Act is repealed.
191. L’article 31 de la Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada est abrogé.
192. Subsection 32(1) of the Act is replaced by the following:
192. Le paragraphe 32(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Annual report

32. (1) The Governing Council shall, within four months after the end of each fiscal year, submit to the Minister a report on the operations and activities of the CIHR in that fiscal year and its strategic directions and goals, and shall include the CIHR’s financial statements.
32. (1) Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, le conseil d’administration présente au ministre un rapport sur les activités d’IRSC au cours de cet exercice, son orientation stratégique et ses objectifs, accompagné des états financiers de celle-ci.
Rapport d’activités